NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED

NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02747765
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG LLP
    PO BOX 695 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CONNAUGHT COMPLIANCE SERVICES GROUP LIMITED24 set 200824 set 2008
    NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED04 mag 200004 mag 2000
    NATIONAL BRITANNIA INVESTMENTS LIMITED08 giu 199908 giu 1999
    NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED01 ago 199301 ago 1993
    NATIONAL BRITANNIA LIMITED08 dic 199208 dic 1992
    VITAPRIME LIMITED16 set 199216 set 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 apr 2013

    20 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 30 apr 2013

    20 pagine2.35B

    Avviso di decadenza dall'incarico da parte dell'amministratore

    33 pagine2.39B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 nov 2012

    33 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 nov 2012

    38 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 mag 2012

    39 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 13 dic 2011

    43 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 lug 2011

    46 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    7 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Llp PO Box 695 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB in data 11 mag 2011

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Santia House Caerphilly Business Park Caerphilly Mid Glamorgan CF83 3GG Wales in data 11 mag 2011

    2 pagineAD01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    66 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    65 pagine2.17B

    Cessazione della carica di Ian Carlisle come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Julia Cavanagh come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di David Wells come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Connaught House Grenadier Road Exeter Business Park Exeter Devon EX1 3QF in data 01 dic 2010

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Segretario
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British146793110001
    DA COSTA, Jean Paul
    2 Vale Court
    21 Mallord Street
    SW3 6AL London
    Segretario
    2 Vale Court
    21 Mallord Street
    SW3 6AL London
    British95259980001
    LOUDEN, Nicholas William
    11 Heol Y Bont
    Rhiwbina
    CF14 6AJ Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario
    11 Heol Y Bont
    Rhiwbina
    CF14 6AJ Cardiff
    South Glamorgan
    British76293900002
    SAUNBY, Kevin David
    Rudgwick
    Westwell Lane Potters Corner
    TN26 1JA Ashford
    Kent
    Segretario
    Rudgwick
    Westwell Lane Potters Corner
    TN26 1JA Ashford
    Kent
    British18474810005
    WELLS, David Francis
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    Segretario
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    BritishAccountant104366980002
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Segretario nominato
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001
    BRUCE, Charles
    Summerdale 8 Greenway Lane
    BA2 4LJ Bath
    Amministratore
    Summerdale 8 Greenway Lane
    BA2 4LJ Bath
    BritishChartered Accountant46553680002
    CARLISLE, Ian
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    EnglandBritishCheif Exceutive146715900001
    DA COSTA, Jean Paul
    2 Vale Court
    21 Mallord Street
    SW3 6AL London
    Amministratore
    2 Vale Court
    21 Mallord Street
    SW3 6AL London
    BritishBarrister95259980001
    EPPS, Stuart Lewis
    17 Idencroft Close
    Pontprennau
    CF23 8PH Cardiff
    Amministratore
    17 Idencroft Close
    Pontprennau
    CF23 8PH Cardiff
    WalesWelshFinancial Director76860630003
    FORD, Peter Michael
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    Amministratore
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    EnglandBritishCompany Director16613000001
    FOX, Richard
    39 Fairview Avenue
    Narbarth Pa
    19072
    Usa
    Amministratore
    39 Fairview Avenue
    Narbarth Pa
    19072
    Usa
    United StatesAmericanBusiness31666810001
    GIBSON, John
    8 Fairways View
    Talbot Green Forest Hills Estate
    CF7 8JG Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    8 Fairways View
    Talbot Green Forest Hills Estate
    CF7 8JG Pontyclun
    Mid Glamorgan
    BritishDirector35357800001
    HEANEY, Quintin John
    Flat 257 County Hall
    Belvedere Road
    SE1 7GH London
    Amministratore
    Flat 257 County Hall
    Belvedere Road
    SE1 7GH London
    United KingdomBritishChartered Accountant112028430001
    HILL, Stephen Ronald
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    Amministratore
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    United KingdomBritishFinance Director115233060001
    HOLROYD, Charles Edward
    Colton Lodge
    Colton
    LS24 8EL Tadcaster
    North Yorkshire
    Amministratore
    Colton Lodge
    Colton
    LS24 8EL Tadcaster
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant1492260001
    LOUDEN, Nicholas William
    11 Heol Y Bont
    Rhiwbina
    CF14 6AJ Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    11 Heol Y Bont
    Rhiwbina
    CF14 6AJ Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritishFinance Director76293900002
    MATTHEWS, Peter Charles
    33 Tower Close
    Bassingbourn
    SG8 5JX Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    33 Tower Close
    Bassingbourn
    SG8 5JX Royston
    Hertfordshire
    BritishDirector14571860001
    PERCY DAVIS, John
    Apartment 9 Charlesworth House
    48 Stanhope Gardens
    SW7 5RD London
    Amministratore
    Apartment 9 Charlesworth House
    48 Stanhope Gardens
    SW7 5RD London
    BritishInsurance Broker74708620005
    PERCY DAVIS, John
    Apartment 9 Charlesworth House
    48 Stanhope Gardens
    SW7 5RD London
    Amministratore
    Apartment 9 Charlesworth House
    48 Stanhope Gardens
    SW7 5RD London
    BritishInsurance Broker74708620005
    PROWSE, John
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    Amministratore
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    EnglandBritishManaging Director96786510001
    RECORD, Anthony
    19 Vincent Square
    Westminster
    SW1P 2NA London
    Amministratore
    19 Vincent Square
    Westminster
    SW1P 2NA London
    EnglandBritishDirector31668130002
    SLEETH, Alexander
    25 Wychwood Park
    CW2 5GP Weston
    Cheshire
    Amministratore
    25 Wychwood Park
    CW2 5GP Weston
    Cheshire
    UkBritishDirector84048730002
    SLEETH, Norman
    6 Redbourne Drive
    Wychwood Park
    CW2 5GH Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    6 Redbourne Drive
    Wychwood Park
    CW2 5GH Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director95565110001
    STEPHENS, Noelyn
    2 Quayside Cottage
    Tinterne
    NP6 6SZ Gwent
    Amministratore
    2 Quayside Cottage
    Tinterne
    NP6 6SZ Gwent
    BritishDirector18846800003
    STOBART, Grant Edwin
    33 Waddling Lane
    Wheathampstead
    AL4 8FD St Albans
    Amministratore
    33 Waddling Lane
    Wheathampstead
    AL4 8FD St Albans
    United KingdomSouth African BritishFinancial Director98434010001
    TATE, Stephen David
    8 Oakfield Avenue
    NP16 5NE Chepstow
    Amministratore
    8 Oakfield Avenue
    NP16 5NE Chepstow
    BritishDirector55781510002
    WALKER, Adrian Peter
    14 Burlington Avenue
    Kew Gardens
    TW9 4DQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    14 Burlington Avenue
    Kew Gardens
    TW9 4DQ Richmond
    Surrey
    EnglandBritishCompany Gardens18474800002
    WALKER, Adrian Peter
    14 Burlington Avenue
    Kew Gardens
    TW9 4DQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    14 Burlington Avenue
    Kew Gardens
    TW9 4DQ Richmond
    Surrey
    EnglandBritishDirector18474800002
    WELLS, David Francis
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    United KingdomBritishAccountant104366980002
    WILTSHIER, John Eric Parham
    The Willows Church Lane
    Petham
    CT4 5RD Canterbury
    Kent
    Amministratore
    The Willows Church Lane
    Petham
    CT4 5RD Canterbury
    Kent
    BritishBusiness Management23610100001
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001

    NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of shares
    Creato il 06 ago 2009
    Consegnato il 25 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 06 ago 2009
    Consegnato il 25 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 10 lug 2009
    Consegnato il 23 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage of shares
    Creato il 10 lug 2009
    Consegnato il 23 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage of shares
    Creato il 15 nov 2007
    Consegnato il 04 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge interest in the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 15 nov 2007
    Consegnato il 04 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Insurance assignment
    Creato il 18 feb 2007
    Consegnato il 28 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Insurer: legal and general. Life assured alex sleeth. Policy number 011367180-4. sum assured: £1,000,000. term: 3YEARS. Commencement date: 02 september 2005. insurer: legal and general. Life assured adrian walker. Policy number 011367268-7 sum assured: £750,000. term: 3YEARS. Commencement date: 02 september 2005 and all emcumbrances and dispositions.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession
    Creato il 29 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All security interests and dispositions created or made by or pursuant to the debenture. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2005
    Consegnato il 19 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 27 set 2001
    Consegnato il 02 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee,the stockholder (as defined) or either of them under the instrument (as defined) or certificate evidencing the loan stock (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alexander Forbes UK PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 14 set 2001
    Consegnato il 21 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1. the policy (as defined), all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it 2. the company's whole right, title and interest present and future in the policy. The policy being:- insurer: norwich union policy no: 7325963EU life assured: stuart epps sum assured £100,000 term of cover: 5 years date of commencement: 27 july 2001.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 24 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 feb 1996
    Consegnato il 20 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade and tenant's fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Confirmatory charge
    Creato il 06 apr 1994
    Consegnato il 22 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 4TH december 1992
    Brevi particolari
    The property and assets of the company as charged by the said mortgage debenture.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    `E' loan note instrument
    Creato il 14 dic 1993
    Consegnato il 30 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of `e' loan note instrument
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Fox Family Partnership
    Transazioni
    • 30 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 dic 1992
    Consegnato il 10 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    "B" loan note instrument
    Creato il 06 nov 1992
    Consegnato il 25 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "b" loan note instrument
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 tc ref: M7C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Richard Fox
    Transazioni
    • 25 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    "A" loan note instrument
    Creato il 06 nov 1992
    Consegnato il 25 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "a" loan note instrument
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 tc ref: M6C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Fox Foundation Partnership
    Transazioni
    • 25 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 feb 2011Inizio dell'amministrazione
    30 apr 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0