THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED

THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02748038
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Marstons House
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 ott 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Stato del capitale al 07 set 2022

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share premium account 05/09/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 set 2022

    • Capitale: GBP 874,158
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 ott 2021

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Anne Marie Brennan come segretario in data 05 ott 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Michelle Louise Woodall come segretario in data 05 ott 2021

    2 pagineAP03

    Nomina di Edward Hancock come amministratore in data 05 ott 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Robert Anthony Leach come amministratore in data 05 ott 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Hayleigh Lupino come amministratore in data 05 ott 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ralph Graham Findlay come amministratore in data 02 ott 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 03 ott 2020

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard James Westwood come amministratore in data 30 ott 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 set 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOODALL, Michelle Louise
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Segretario
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    288186710001
    ANDREA, Andrew Andonis
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director137383120001
    HANCOCK, Edward John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor288133210001
    LEACH, Robert Anthony
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Treasury194085550001
    LUPINO, Hayleigh
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director207826950002
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Segretario
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    British125526410001
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Segretario
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRENNAN, Anne Marie
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Secretary109935620001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    Segretario
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    BritishCompany Director65460520003
    SHAH, Vimal
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    Segretario
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    British4692040001
    WEST, Alan
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishFinancial Controller111318570001
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    Segretario
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    106817380001
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Amministratore
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    EnglandBritishChartered Accountant125526410001
    ANDREW, Derek
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director39071260003
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director65460520003
    CHOWDHARY, Balvinder Kaur
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Registration Agent4672940001
    COYLE, James Arthur
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    Amministratore
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishSales Director63364040001
    DALZELL, Peter
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director163616170001
    DARBY, Alistair William
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director87846880002
    DAVIES, Martin William Oliver
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    BritishManaging Director40444030001
    DENNING, Roland John
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    Amministratore
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director95991510001
    FINDLAY, Ralph Graham
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director129897400001
    GRACE, David Allen
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    Amministratore
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    BritishCompany Director67926560001
    HAWTHORN, Stuart John
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    BritishDirector82240190001
    INGLETT, Paul
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director81617110002
    LUSCOMBE, Richard William
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    Amministratore
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    BritishCompany Director70464690001
    MOSS, Arthur Christopher
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    BritishBrewer30700880001
    OLIVER, Stephen John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director66123690003
    ROGERS, Ian
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    BritishManaging Director30700870003
    THOMPSON, Rupert Geoffrey Ryland
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    Amministratore
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    EnglandBritishCompany Director30939200001
    WESTWOOD, Richard James
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director314691870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03981399
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 08 lug 2002
    Consegnato il 09 lug 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 09 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 14 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 29 ott 1999
    Consegnato il 10 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 gen 1998
    Consegnato il 22 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Book debts debenture
    Creato il 28 ott 1996
    Consegnato il 30 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future save for those book debts and other debts sold by the company and purchased by the chargee under an invoice discounting agreement and not purchased pursuant to the provisions thereof.
    Persone aventi diritto
    • New Court Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 30 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 apr 1995
    Consegnato il 19 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Leasehold property known as units 10 and 11 eagle industrial estate the crofts witney oxfordshire title number ON172245 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 apr 1995
    Consegnato il 19 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Leasehold property known as unit 12 eagle industrial estate witney oxfordshire title number ON169190 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 17 ott 1994
    Consegnato il 21 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from hobgoblinns limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Counterpart rent deposit deed
    Creato il 11 ago 1994
    Consegnato il 12 ago 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of a lease dated 11TH august 1994 and this deed
    Brevi particolari
    £1066 or one quarter of the annual rent from time to time payable under the said lease dated 11TH august 1994 (whichever shall be the greater) together with a sum equivalent to the rate of V.A.T. currently charged on rent.
    Persone aventi diritto
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    Transazioni
    • 12 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed incorporating charge
    Creato il 12 mag 1994
    Consegnato il 13 mag 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of the lease dated 12TH may 1994.
    Brevi particolari
    £5,529 and all other monies deposited in the deposit account at lloyds bank PLC in the name of the chargee.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    Transazioni
    • 13 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 lug 1993
    Consegnato il 08 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 giu 1993
    Consegnato il 07 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-unit 9B two rivers industrial estate station lane witney oxfordshire. T/n-ON111965 and ON139732 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0