THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED
Panoramica
Nome della società | THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02748038 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Marstons House Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton West Midlands |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 02 ott 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 07 set 2022
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 set 2022
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 02 ott 2021 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anne Marie Brennan come segretario in data 05 ott 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Michelle Louise Woodall come segretario in data 05 ott 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Nomina di Edward Hancock come amministratore in data 05 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Robert Anthony Leach come amministratore in data 05 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Hayleigh Lupino come amministratore in data 05 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ralph Graham Findlay come amministratore in data 02 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 03 ott 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard James Westwood come amministratore in data 30 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 set 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOODALL, Michelle Louise | Segretario | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | 288186710001 | |||||||
ANDREA, Andrew Andonis | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | England | British | Company Director | 137383120001 | ||||
HANCOCK, Edward John | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 288133210001 | ||||
LEACH, Robert Anthony | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Treasury | 194085550001 | ||||
LUPINO, Hayleigh | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 207826950002 | ||||
ADAMS, Paul Francis | Segretario | Thurston House Weston Road BA1 2XU Bath | British | 125526410001 | ||||||
BIRCH, James | Segretario | 7 Woods Close Sherston SN16 0LF Malmesbury Wiltshire | British | Director | 116449180001 | |||||
BRENNAN, Anne Marie | Segretario | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | Company Secretary | 109935620001 | |||||
BRYAN, Nicholas George | Segretario | 8 The Breach SN10 5BJ Devizes Wiltshire | British | Company Director | 65460520003 | |||||
SHAH, Vimal | Segretario | 9 Southfield Road Chiswick W4 1AG London | British | 4692040001 | ||||||
WEST, Alan | Segretario | 29 Oak Manor Drive GL52 6SZ Cheltenham Gloucestershire | British | Financial Controller | 111318570001 | |||||
BONDLAW SECRETARIES LIMITED | Segretario | 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | 106817380001 | |||||||
ADAMS, Paul Francis | Amministratore | Thurston House Weston Road BA1 2XU Bath | England | British | Chartered Accountant | 125526410001 | ||||
ANDREW, Derek | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | Company Director | 39071260003 | |||||
BIRCH, James | Amministratore | 7 Woods Close Sherston SN16 0LF Malmesbury Wiltshire | British | Director | 116449180001 | |||||
BRYAN, Nicholas George | Amministratore | 8 The Breach SN10 5BJ Devizes Wiltshire | England | British | Company Director | 65460520003 | ||||
CHOWDHARY, Balvinder Kaur | Amministratore | 112 Park Road Hampton Hill TW12 1HR Hampton Middlesex | England | British | Company Registration Agent | 4672940001 | ||||
COYLE, James Arthur | Amministratore | Glen Ruther College Road Denstone ST14 5HR Uttoxeter Staffordshire | British | Sales Director | 63364040001 | |||||
DALZELL, Peter | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | Company Director | 163616170001 | ||||
DARBY, Alistair William | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | Company Director | 87846880002 | |||||
DAVIES, Martin William Oliver | Amministratore | Dancing Waters The Friary SL4 2NS Old Windsor Berkshire | British | Managing Director | 40444030001 | |||||
DENNING, Roland John | Amministratore | Swallowfield Grange The Street RG7 1RE Swallowfield Berkshire | England | British | Company Director | 95991510001 | ||||
FINDLAY, Ralph Graham | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marstons House West Midlands | England | British | Company Director | 129897400001 | ||||
GRACE, David Allen | Amministratore | Lark Rise Home Farm Court East End Adderbury OX17 3NW Banbury Oxon | British | Company Director | 67926560001 | |||||
HAWTHORN, Stuart John | Amministratore | 3 Rutherford Close OX14 2AT Abingdon Oxfordshire | British | Director | 82240190001 | |||||
INGLETT, Paul | Amministratore | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | Company Director | 81617110002 | |||||
LUSCOMBE, Richard William | Amministratore | Lauriston House Town Barton, Norton St. Philip BA2 7LN Bath Avon | British | Company Director | 70464690001 | |||||
MOSS, Arthur Christopher | Amministratore | 80 Bridge Street OX2 0BD Oxford Oxfordshire | British | Brewer | 30700880001 | |||||
OLIVER, Stephen John | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | Company Director | 66123690003 | |||||
ROGERS, Ian | Amministratore | 17 Burcott Park Burcott OX14 3DH Abingdon Oxfordshire | British | Managing Director | 30700870003 | |||||
THOMPSON, Rupert Geoffrey Ryland | Amministratore | The Hermitage RG17 0HA Hungerford Berks | England | British | Company Director | 30939200001 | ||||
WESTWOOD, Richard James | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | Company Director | 314691870001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refresh Group Limited | 06 apr 2016 | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Creato il 08 lug 2002 Consegnato il 09 lug 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 giu 2002 Consegnato il 14 giu 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 ott 1999 Consegnato il 10 nov 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 19 gen 1998 Consegnato il 22 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Book debts debenture | Creato il 28 ott 1996 Consegnato il 30 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future save for those book debts and other debts sold by the company and purchased by the chargee under an invoice discounting agreement and not purchased pursuant to the provisions thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 10 apr 1995 Consegnato il 19 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Leasehold property known as units 10 and 11 eagle industrial estate the crofts witney oxfordshire title number ON172245 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 10 apr 1995 Consegnato il 19 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Leasehold property known as unit 12 eagle industrial estate witney oxfordshire title number ON169190 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Collateral debenture | Creato il 17 ott 1994 Consegnato il 21 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from hobgoblinns limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Counterpart rent deposit deed | Creato il 11 ago 1994 Consegnato il 12 ago 1994 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of a lease dated 11TH august 1994 and this deed | |
Brevi particolari £1066 or one quarter of the annual rent from time to time payable under the said lease dated 11TH august 1994 (whichever shall be the greater) together with a sum equivalent to the rate of V.A.T. currently charged on rent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed incorporating charge | Creato il 12 mag 1994 Consegnato il 13 mag 1994 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of the lease dated 12TH may 1994. | |
Brevi particolari £5,529 and all other monies deposited in the deposit account at lloyds bank PLC in the name of the chargee.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 01 lug 1993 Consegnato il 08 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 24 giu 1993 Consegnato il 07 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H-unit 9B two rivers industrial estate station lane witney oxfordshire. T/n-ON111965 and ON139732 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0