MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED

MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMULTI-TECH CONTRACTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02749500
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED?

    • Altre attività di ingegneria (71129) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 71 Victoria Street London SW1H 0XA

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 71 Victoria Street London SW1H 0XA

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 17 Rochester Row Westminster London SW1P 1QT a 1 More London Place London SE1 2AF in data 19 apr 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 mar 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di Mrs Francesca Anne Todd come amministratore in data 05 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Patrick Dwyer come amministratore in data 05 mar 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Ian Edward Jarvis come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Patrick Dwyer come amministratore in data 01 gen 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Ian Edward Jarvis come amministratore in data 21 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel James Greenspan come amministratore in data 21 gen 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ott 2015

    Stato del capitale al 26 ott 2015

    • Capitale: GBP 300
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ott 2014

    Stato del capitale al 17 ott 2014

    • Capitale: GBP 300
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ott 2013

    Stato del capitale al 15 ott 2013

    • Capitale: GBP 300
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Segretario
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2376959
    135207160001
    TODD, Francesca Anne
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish72249980002
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5641516
    129795770003
    BONNON, Elaine Anne
    19 Gregson Road
    WA8 0BX Widnes
    Cheshire
    Segretario
    19 Gregson Road
    WA8 0BX Widnes
    Cheshire
    British60273870001
    FLYNN, David Robert
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    British34208920001
    HUGHES, David George, Mr.
    Spindrift 65 Pipers Lane
    Heswall
    CH60 9HY Wirral
    Merseyside
    Segretario
    Spindrift 65 Pipers Lane
    Heswall
    CH60 9HY Wirral
    Merseyside
    British27551220001
    PLANT, David John, Mr.
    449 London Road
    Davenham
    CW9 8NH Northwich
    Cheshire
    Segretario
    449 London Road
    Davenham
    CW9 8NH Northwich
    Cheshire
    British59672970003
    ROGERSON, David
    1 Clifford Road
    Poynton
    SK12 1HY Stockport
    Cheshire
    Segretario
    1 Clifford Road
    Poynton
    SK12 1HY Stockport
    Cheshire
    British1586290001
    SANDERSON, Matthew Alexander
    Coronation Drive
    Penketh
    WA5 2DD Warrington
    51
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Coronation Drive
    Penketh
    WA5 2DD Warrington
    51
    Cheshire
    United Kingdom
    British138138360001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    DWYER, David Patrick
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish201097350001
    GARVEY, Kevin John
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    Amministratore
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    United KingdomBritish80893800001
    GREENSPAN, Daniel James
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    United KingdomBritish125130890002
    IRELAND, Leslie
    48 Grappenhall Road
    Stockton Heath
    WA4 2AG Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    48 Grappenhall Road
    Stockton Heath
    WA4 2AG Warrington
    Cheshire
    British27322340001
    JARVIS, Ian Edward
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish184235890001
    JENNINGS, Timothy
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    Amministratore
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    EnglandBritish149372130001
    MCGEE, John Wilson
    9 Weybridge Close
    Appleton
    WA4 5LZ Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    9 Weybridge Close
    Appleton
    WA4 5LZ Warrington
    Cheshire
    British27322330001
    PLANT, David John, Mr.
    449 London Road
    Davenham
    CW9 8NH Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    449 London Road
    Davenham
    CW9 8NH Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish59672970003
    RANDLES, John Jeffrey
    47 Inglewood Road
    Rainford
    WA11 7QL St. Helens
    Merseyside
    Amministratore
    47 Inglewood Road
    Rainford
    WA11 7QL St. Helens
    Merseyside
    British82250960002
    SANDERSON, Matthew Alexander
    Coronation Drive
    Penketh
    WA5 2DD Warrington
    51
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Coronation Drive
    Penketh
    WA5 2DD Warrington
    51
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish138138360001
    SMOOTHY, Michael
    The Dairy House
    Hill View Road
    WR8 9LJ Lower Strensham
    Worcester
    Amministratore
    The Dairy House
    Hill View Road
    WR8 9LJ Lower Strensham
    Worcester
    British108028330001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Victoria Street
    SW1H 0XA Westminster
    71
    London
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Victoria Street
    SW1H 0XA Westminster
    71
    London
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02018542
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 23 ago 2007
    Consegnato il 25 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1C charnwood park bridgend. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 2005
    Consegnato il 03 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a unit 6 + 7 bowood court, calver rd, warrington. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 nov 2005
    Consegnato il 30 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 06 mar 2001
    Consegnato il 14 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 feb 2001
    Consegnato il 20 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • City Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 20 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 28 feb 2000
    Consegnato il 01 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,187.50 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £2,187.50.
    Persone aventi diritto
    • Michael Anthony Cowan, Jacqueline Ann Cowan, Jeffrey Cowan and Hanmere Polythene Limitedknown as the Hanmere Cowan Joint Venture
    Transazioni
    • 01 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MULTI-TECH CONTRACTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 mar 2018Inizio della liquidazione
    15 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0