G2 INTERACTIVE LIMITED
Panoramica
Nome della società | G2 INTERACTIVE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02749663 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di G2 INTERACTIVE LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova G2 INTERACTIVE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Sea Containers 18 Upper Ground SE1 9RQ London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di G2 INTERACTIVE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GREY INTERACTIVE SERVICES LIMITED | 12 ott 1999 | 12 ott 1999 |
MODULE COMMUNICATIONS GROUP LIMITED | 18 feb 1997 | 18 feb 1997 |
COMUNIK 8 LIMITED | 23 set 1992 | 23 set 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di G2 INTERACTIVE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per G2 INTERACTIVE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 21 giu 2023
| 3 pagine | SH01 | ||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Wpp Group (Nominees) Limited il 26 nov 2018 | 1 pagine | CH04 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 121-141 Westbourne Terrace Paddington London England and Wales W2 6JR a Sea Containers 18 Upper Ground London SE1 9RQ in data 30 mar 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 10 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 9 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Wayne Moretto come amministratore in data 10 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Sarah Todd come amministratore in data 02 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Ms Michelle Whelan come amministratore in data 02 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di G2 INTERACTIVE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED | Segretario | 18 Upper Ground SE1 9GL London Sea Containers House United Kingdom |
| 80143770001 | ||||||||||
WHELAN, Michelle | Amministratore | 18 Upper Ground SE1 9RQ London Sea Containers England | England | Irish | Company Director | 186341510001 | ||||||||
EGAN, David Anthony | Segretario | 28 Glebe Road Barnes SW13 0EA London | Irish | Company Director | 235270001 | |||||||||
GRIFFITHS, Sally Jane | Segretario | 83 Brian Avenue CR2 9NJ South Croydon Surrey | British | 91601070001 | ||||||||||
LYSIONEK, Susan Mary | Segretario | Nightingales GU3 1DT Compton Surrey | British | 78777420001 | ||||||||||
MARKS, Stuart Adam | Segretario | Broadmead 20 Broad Lane Hale WA15 0DF Altrincham Cheshire | British | 63485870002 | ||||||||||
SHAYLER, Clive Frank | Segretario | The Old School House Leicester Road Sapcote LE9 4JE Leicester Leicestershire | British | 3273150001 | ||||||||||
SHAYLER, Sandra Pauline | Segretario | The Old Barn 28 Main Street Carlton CV13 0EZ Market Bosworth Leicestershire | British | 3273160002 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
ANDREWS, Vanessa Lorraine | Amministratore | The Johnson Building 77 Hatton Garden EC1N 8JS London | United Kingdom | New Zealand | Company Director | 137277880001 | ||||||||
CARTER, Neil Jason | Amministratore | Westbourne Terrace Paddington W2 6JR London 121-141 England And Wales United Kingdom | England | British | Cfo | 201982900001 | ||||||||
CUNNINGHAM, Stephen George | Amministratore | Walnut Tree Cottage Peasemore RG20 7JJ Newbury Berkshire | England | British | Sales Director | 51563570001 | ||||||||
DADRA, Raj Kumar | Amministratore | Westbourne Terrace Paddington W2 6JR London 121-141 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 88610840005 | ||||||||
DICKENS, Christopher | Amministratore | 163 Craddocks Avenue KT21 1NT Ashtead Surrey | British | Company Director | 60964090001 | |||||||||
EGAN, David Anthony | Amministratore | 28 Glebe Road Barnes SW13 0EA London | England | Irish | Company Director | 235270001 | ||||||||
FARR, Neil Stephen | Amministratore | 68 Latimer Road Cropston LE7 7GN Leicester Leicestershire | British | Director | 29666660001 | |||||||||
GRIFFITHS, Sally Jane | Amministratore | 83 Brian Avenue CR2 9NJ South Croydon Surrey | British | Chartered Secretary | 91601070001 | |||||||||
HINCHLIFFE, Steven Ashley | Amministratore | 68a Grove Park Terrace W4 3JL London | British | Company Director | 9787840003 | |||||||||
HIRST, William Jonathan Tennyson | Amministratore | 136 East 64th Street Apt 5e 10021 New York City New York Usa | British | Fin Director | 54734880001 | |||||||||
LEE, Brian | Amministratore | 12/15a Courtfield Road SW7 4DA London | Irish | Advertising Executive | 63174180001 | |||||||||
LINNELL, Peter John | Amministratore | Rivers Reach Hamm Court KT13 8YA Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Financial Director | 63174210002 | ||||||||
MARKS, Stuart Adam | Amministratore | Broadmead 20 Broad Lane Hale WA15 0DF Altrincham Cheshire | England | British | Company Director | 63485870002 | ||||||||
MARKWICK, Janet Ann | Amministratore | Baughurst Road Baughurst RG26 5LL Tadley Downsview House Hants United Kingdom | England | British | Company Director | 128210380001 | ||||||||
MORETTO, Wayne | Amministratore | W2 6JR Paddington 121-141 Westbourne Terrace London England | England | British | Cfo | 181548140001 | ||||||||
RULE, Simon James | Amministratore | 14 Blakeney Road BR3 1HD Beckenham Kent | British | Company Director | 18884950001 | |||||||||
RULE, Simon James | Amministratore | 14 Blakeney Road BR3 1HD Beckenham Kent | British | Company Director | 18884950001 | |||||||||
SHAH, Binit | Amministratore | The Johnson Building 77 Hatton Garden EC1N 8JS London | United Kingdom | British | Company Director | 134126980001 | ||||||||
SHANNON, Oliver John Christopher | Amministratore | 59 Cumberland Terrace NW1 4HJ Regents Park London | Irish | Advertising Executive | 71767830003 | |||||||||
SHAYLER, Clive Frank | Amministratore | The Old School House Leicester Road Sapcote LE9 4JE Leicester Leicestershire | British | Managing Director | 3273150001 | |||||||||
SHAYLER, Sandra Pauline | Amministratore | The Old Barn 28 Main Street Carlton CV13 0EZ Market Bosworth Leicestershire | British | Director | 3273160002 | |||||||||
SHIRTCLIFFE, Lisa Jane | Amministratore | The Johnson Building 77 Hatton Garden EC1N 8JS London | United Kingdom | British | Finance Director | 154009530001 | ||||||||
STITCHER, Robert | Amministratore | Flat 2 7 Netherhall Gardens NW3 5RN London | British | Finance Director | 82486170002 | |||||||||
TAYLER, Joanne Margaret | Amministratore | 14 Chancery Mews Wandsworth Common SW17 7TD London | United Kingdom | British | Finance Manager | 97179050002 | ||||||||
TODD, Sarah | Amministratore | London The Company's Registered Office | United Kingdom | British | Company Director | 175296400001 | ||||||||
VLESSING, Marc Ferdinand | Amministratore | 35 Camden Square NW1 9XA London | England | British,Dutch | Company Director | 38273660001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di G2 INTERACTIVE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module Communications Group Limited | 23 set 2016 | Hatton Garden EC1N 8JS London 77 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
G2 INTERACTIVE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 16 gen 2001 Consegnato il 22 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 gen 1998 Consegnato il 06 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 ago 1994 Consegnato il 31 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0