FLEXIT IH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFLEXIT IH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02752646
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FLEXIT IH LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova FLEXIT IH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FLEXIT IH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHAREBALANCE PUBLIC LIMITED COMPANY02 ott 199202 ott 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di FLEXIT IH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per FLEXIT IH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Booths Park Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8QZ in data 16 gen 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 17 dic 2009

    LRESSP

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FLEXIT IH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAND, Kim Andrea
    Sutton Field
    Whitegate
    CW8 2BD Northwich
    Cherry Trees,
    Cheshire
    Segretario
    Sutton Field
    Whitegate
    CW8 2BD Northwich
    Cherry Trees,
    Cheshire
    British141032930001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Amministratore
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Secretary141025870003
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    32732300002
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Secretary800670001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Segretario
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Segretario
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    BritishChartered Accountant4689630002
    SHELDON, Jeremy Nigel
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    Segretario
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    BritishSolicitor80327250001
    RICHARD ELLIS FINANCIAL LIMITED
    C/O Richard Ellis
    55 Old Broad Street
    EC2M 1LP London
    Segretario
    C/O Richard Ellis
    55 Old Broad Street
    EC2M 1LP London
    32874470003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant28998990001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant28998990001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant28998990001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    IrishAccountant6552570001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    IrishAccountant6552570001
    ELLINGHAM, Hugh Vere Alexander
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishChartered Surveyor36926690001
    FITZGERALD, Michael Thomas
    Whin Cottage St Michaels Drive
    TN14 5SA Otford
    Kent
    Amministratore
    Whin Cottage St Michaels Drive
    TN14 5SA Otford
    Kent
    BritishAccountant62403370002
    FRASER, Richard Lindsay
    Meadowgarth Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Meadowgarth Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director13770640001
    HOLLAND, Peter James
    Woodside House
    Wynnstay Lane, Marford
    LL12 8LH Wrexham
    Amministratore
    Woodside House
    Wynnstay Lane, Marford
    LL12 8LH Wrexham
    WalesBritishChartered Accountant75624260001
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    BritishCompany Director4689630002
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    BritishChartered Accountant4689630002
    PEARCE, Daniel Norton Idris, Sir
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    Amministratore
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    BritishChartered Surveyor45656280001
    RATCLIFFE, Michael Arthur
    9 Leigh Court Close
    KT11 2HT Cobham
    Surrey
    Amministratore
    9 Leigh Court Close
    KT11 2HT Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director11387510001
    ROUGHTON, Dominic David
    10 Danbury Street
    Islington
    N1 8JU London
    Amministratore
    10 Danbury Street
    Islington
    N1 8JU London
    BritishTrainee Solicitor30738920001
    SHELDON, Jeremy Nigel
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    BritishSolicitor80327250001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    FLEXIT IH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1994
    Consegnato il 03 giu 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 58 regents gate foxholes hertford hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 19 apr 1994
    Consegnato il 20 apr 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 58 on the company's estate at phase 2(a) regents gate foxholes, hertford hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1994
    Consegnato il 10 feb 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 14 crusaders court st. Johns terrace road earlswood redhill, plots 9 17 and 25 manor drive wembley. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1994
    Consegnato il 10 feb 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993
    Brevi particolari
    Plot 160 carreg yr afon glan yr afon graig newydd godre'r graig pontardawe west glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1994
    Consegnato il 10 feb 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993
    Brevi particolari
    Plot 78 herons reach blackpool.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 21 dic 1993
    Consegnato il 07 gen 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 43 impala drive cherry hinton.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 1993
    Consegnato il 01 dic 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 150.3 glan-yr-afon, godre'r graig, pontardawe, swansea.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 nov 1993
    Consegnato il 17 nov 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plots 32,33,34 and 39 salters lane, waterside mews, newport.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 01 nov 1993
    Consegnato il 02 nov 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 115 cyclops wharf, west ferry road, london.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 1993
    Consegnato il 15 ott 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plots 169 and 170 barley croft, station road, elmswell, suffolk.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 14 set 1993
    Consegnato il 21 set 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to 11.1 of the put and call option deed dated 14/1/93
    Brevi particolari
    Plot 88 herons reach blackpool.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 lug 1993
    Consegnato il 05 ago 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 902 cyclops wharf, west ferry road, london.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 1993
    Consegnato il 07 ago 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 502 cyclops wharf west ferry road, london.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 1993
    Consegnato il 23 lug 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14/1/193
    Brevi particolari
    Plots 95, 32, 29 and 49 spring gardens ince.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 02 lug 1993
    Consegnato il 07 lug 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 144 godre'r graig, swansea.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 25 giu 1993
    Consegnato il 02 lug 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    326 cyclops wharf, west ferry road, london.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 24 giu 1993
    Consegnato il 02 lug 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    516 cyclops wharf, west ferry road, london.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 04 giu 1993
    Consegnato il 17 giu 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Plots 2.01, 5.16 and 6.19 king and queen wharf, rotherhithe. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 17 mag 1993
    Consegnato il 20 mag 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Plots 59,64,65 willow green,robertsbridge; plot 45 lytton gate,woolmer green.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1993
    Consegnato il 25 feb 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brevi particolari
    Plot 7 on the company's estate at the ridings, paddock wood t/no: k 684686 (see ch microfiche for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 14 gen 1993
    Consegnato il 01 feb 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call options deed of even date and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    See 395 for full details and property details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)

    FLEXIT IH LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 dic 2009Inizio della liquidazione
    10 apr 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher John Brown
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire
    Praticante
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0