NEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC

NEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 02753309
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova NEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Bridge House
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per NEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 lug 2012

    9 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 nov 2011

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da Port of Liverpool Building Pier Head Liverpool Merseyside L3 1NW in data 17 nov 2011

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 nov 2011

    Stato del capitale al 02 nov 2011

    • Capitale: GBP 754,656.98
    SH01

    Cessazione della carica di Edward James Wingfield Lifford come amministratore in data 20 ott 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edward James Wingfield Lifford come amministratore in data 20 ott 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Paul Dominic Grant Chavasse come amministratore in data 20 ott 2011

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di Harold Cunningham come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    9 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    9 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    9 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    12 pagineAA

    Varie

    Sect 394
    1 pagineMISC

    legacy

    8 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di NEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VERNON, Jeffrey Barry
    21 Mount Road
    West Kirby
    CH48 2HH Wirral
    Merseyside
    Segretario
    21 Mount Road
    West Kirby
    CH48 2HH Wirral
    Merseyside
    British67644690002
    CHAVASSE, Paul Dominic Grant
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    Amministratore
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    UkBritishChief Operting Officer78252330002
    DODD, Lorraine Antonia Carrol
    Tyn Twll Plas Lane
    Llanarmon Yn Ial
    CH7 4QJ Mold
    Flintshire
    Amministratore
    Tyn Twll Plas Lane
    Llanarmon Yn Ial
    CH7 4QJ Mold
    Flintshire
    United KingdomBritishStockbroker12179800004
    CLEGG, John Lescher
    Flat 6a 6 Park Road
    West Kirby
    L48 4DW Wirral
    Merseyside
    Segretario
    Flat 6a 6 Park Road
    West Kirby
    L48 4DW Wirral
    Merseyside
    BritishAccountant16927950002
    BANKES, Nicholas David
    Ty Ucha'R Llan
    Cilcain
    CH7 5PA Mold
    Flintshire
    Amministratore
    Ty Ucha'R Llan
    Cilcain
    CH7 5PA Mold
    Flintshire
    WalesBritishStockbroker19483030001
    CLEGG, John Lescher
    Flat 6a 6 Park Road
    West Kirby
    L48 4DW Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Flat 6a 6 Park Road
    West Kirby
    L48 4DW Wirral
    Merseyside
    BritishAccountant16927950002
    CUNNINGHAM, Harold Michael Clunie, Mr
    Dolhyfryd
    Lawnt
    LL16 4SU Denbigh
    Clwyd
    Amministratore
    Dolhyfryd
    Lawnt
    LL16 4SU Denbigh
    Clwyd
    United KingdomBritishStockbroker17431410001
    DUSSARTRE, Jane Mary
    Saints Hill House
    Saints Hill Penshurst
    TN11 8EN Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Saints Hill House
    Saints Hill Penshurst
    TN11 8EN Tonbridge
    Kent
    BritishStockbroker49932730002
    HARVEY, Ian Pearce
    27 Landford Road
    Putney
    SW15 1AQ London
    Amministratore
    27 Landford Road
    Putney
    SW15 1AQ London
    United KingdomBritishChartered Accountant39438930001
    INGALL, Michael Lenox
    23 Lansdowne Road
    W11 3AG London
    Amministratore
    23 Lansdowne Road
    W11 3AG London
    BritishInvestment Consultant35314210002
    LIFFORD, Edward James Wingfield, The Viscount
    Field House
    Hursley
    SO21 2LE Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Field House
    Hursley
    SO21 2LE Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishStockbroker14020560001
    MORRIS, Roy Alfred
    Mad Wharf House
    35 Shireburn Road, Formby
    L37 1LR Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Mad Wharf House
    35 Shireburn Road, Formby
    L37 1LR Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritishCompany Director5638380002
    NEWMAN, Rodney
    14 Firs Drive
    Hedge End
    SO30 4QL Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    14 Firs Drive
    Hedge End
    SO30 4QL Southampton
    Hampshire
    BritishStockbroker18476040001
    PEARSON, Mark Hadden
    The Hollies
    Vyner Road South
    L43 7PW Birkenhead
    Merseyside
    Amministratore
    The Hollies
    Vyner Road South
    L43 7PW Birkenhead
    Merseyside
    BritishStockbroker14020610001
    RAVENSCROFT, Anthony James
    The Hollies 14 Mount Pleasant
    Oxton
    L43 5SY Birkenhead
    Merseyside
    Amministratore
    The Hollies 14 Mount Pleasant
    Oxton
    L43 5SY Birkenhead
    Merseyside
    BritishStockbroker14020600001
    RENISON, Peter John
    Hadlow Wood Hadlow Road
    Willaston
    L64 2UN South Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Hadlow Wood Hadlow Road
    Willaston
    L64 2UN South Wirral
    Merseyside
    BritishStockbroker19389160001
    SAWBRIDGE, Michael John
    31 Selworthy Road
    Birkdale
    PR8 2NS Southport
    Merseyside
    Amministratore
    31 Selworthy Road
    Birkdale
    PR8 2NS Southport
    Merseyside
    United KingdomBritishStockbroker11107530001
    SPIEGELBERG, John Francis
    Church Croft
    Davenham
    CW9 8NF Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Church Croft
    Davenham
    CW9 8NF Northwich
    Cheshire
    BritishStockbroker16927960001
    WALLS, William Anthony
    17 Saxon Road
    Birkdale
    PR8 2AX Southport
    Merseyside
    Amministratore
    17 Saxon Road
    Birkdale
    PR8 2AX Southport
    Merseyside
    BritishStockbroker15030670001

    NEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment
    Creato il 08 gen 1996
    Consegnato il 10 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter dated 4TH august 1993 (as amended by a facility letter dated 22ND december 1995)
    Brevi particolari
    All the rights,title,interest in and all benefits accruing from the loan agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 10 ago 1993
    Consegnato il 27 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 04.08.93
    Brevi particolari
    All the companys's right title and interest in a loan agreement dated 10.08.93. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 ago 1993
    Consegnato il 27 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 04.08.93
    Brevi particolari
    By way of fixed charge monies held in an account with the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 ago 1993
    Consegnato il 24 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of pledge
    Creato il 10 ago 1993
    Consegnato il 24 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stocks shares bonds debentures or other securities of any description. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NEILSON COBBOLD HOLDINGS PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 nov 2011Inizio della liquidazione
    17 ott 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Paul Grant
    Wilkins Kennedy Llp Bridge House
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Praticante
    Wilkins Kennedy Llp Bridge House
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Anthony Malcolm Cork
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    Praticante
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0