PRESTIGIC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRESTIGIC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02757109
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRESTIGIC LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova PRESTIGIC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    42 Albemarle Street
    London
    W1S 4JH
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRESTIGIC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PRESTIGIC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ott 2015

    Stato del capitale al 28 ott 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Philip Thomas Dawes come segretario in data 31 mag 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2014

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 dic 2014

    Stato del capitale al 04 dic 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2013

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ott 2013

    Stato del capitale al 22 ott 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2012

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mag 2011

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mag 2010

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mag 2009

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Adrian Goldsmith il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2008

    16 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di PRESTIGIC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOLDSMITH, Adrian Richard
    30 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    Greater London
    Amministratore
    30 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    Greater London
    United KingdomBritish48240460001
    DAWES, Philip Thomas
    3 Blackmile Lane
    Grendon
    NN7 1JR Northampton
    Northants
    Segretario
    3 Blackmile Lane
    Grendon
    NN7 1JR Northampton
    Northants
    British87840550002
    GREEN, Jonathan Swale
    Flat 5
    153 Sutherland Avenue
    W9 1ES London
    Segretario
    Flat 5
    153 Sutherland Avenue
    W9 1ES London
    British103086380001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Segretario
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    MADDEN, Sarah Joy
    104 Stephendale Road
    SW6 2PH London
    Segretario
    104 Stephendale Road
    SW6 2PH London
    British65668820001
    VAN ROOYEN, Tracy
    30 Edgewood Drive
    Green Street Green
    BR6 6LQ Orpington
    Kent
    Segretario
    30 Edgewood Drive
    Green Street Green
    BR6 6LQ Orpington
    Kent
    British67908740002
    WALDEN, Susan Tracy
    31 Brechin Place
    SW7 4QD London
    Segretario
    31 Brechin Place
    SW7 4QD London
    British40398340002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    HARRIS, Michael Roderick
    Sandgate
    Marley Way, Storrington
    RH20 3NH Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Sandgate
    Marley Way, Storrington
    RH20 3NH Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritish4768360001
    TCHENGUIZ, Robert
    6 Chesterfield Hill
    Mayfair
    W1J 5BL London
    Amministratore
    6 Chesterfield Hill
    Mayfair
    W1J 5BL London
    Iranian74322720002
    TCHENGUIZ, Vincent Aziz
    3 Lees Place
    Mayfair
    W1K 6LH London
    Amministratore
    3 Lees Place
    Mayfair
    W1K 6LH London
    United KingdomBritish71890500003
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PRESTIGIC LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Prestigic Holdings Limited
    Albemarle Street
    W1S 4JH London
    42
    England
    06 apr 2016
    Albemarle Street
    W1S 4JH London
    42
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione03256692
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PRESTIGIC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed being supplemental to a deed of legal charge dated 27 march 1998
    Creato il 28 mag 2003
    Consegnato il 10 giu 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from prestigic holdings limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h land being 3 & 4 vaughan parade and 3 palk street torquay devon t/no DN339269 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transazioni
    • 10 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment
    Creato il 28 mag 2003
    Consegnato il 10 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from prestigic holdings limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the rights titles benefits and interests whether present or future of the company to all moneys from time to time due owing or incurred to the company under the leases in respect of l/h property k/a 3 & 4 vaughan parade and 3 palk street torquay t/no DN339269. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transazioni
    • 10 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of charge
    Creato il 27 mar 1998
    Consegnato il 15 apr 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilites whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by prestigic holdings limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of prestigic holdings limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, the norwich union mortgage finance limited and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed moneys by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever and in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    The company assigns by way of charge all the rights, titles, benefits and interests and whether present or future of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of 27 crown street leeds, 328 and 330 chepstow road newport gwent, 2-4 albert road wildnes and 6-7 high street market drayton ("the lease/s") other than the sums due to the company by way of insurance rent or service charge or any vat payable to the company thereon including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof now or at any time thereafter given together with all claims, causes of action and damages arising in connection therewith and any proceeds of the forgoing ("the assigned rights").. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of legal charge
    Creato il 27 mar 1998
    Consegnato il 15 apr 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilites whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by prestigic holdings limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of prestigic holdings limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, the norwich union mortgage finance limited and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed moneys by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever and in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    The properties listed below together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance: 27 crown street leeds t/n-WYK193950. 328 and 330 chepstow road newport t/n-WA236678. 2 and 4 albert road widnes cheshire t/n-CH339908. 6-7 high street market drayton shropshire t/n-SL53053. Manvers house kingston mills bradford upon avon wiltshire t/n-WT141611. All monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed. By way of floating charge the whole of the company's property, assets, rights and revenues whatsoever and wheresoever, present and future, including the uncalled share capital (if any) or such of them as the context requires.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 24 feb 1997
    Consegnato il 14 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from holaw (332) limited and prestigic limited (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders or the chargee and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 2 & 3 burrington way,plymouth-DN323936 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants'fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto.all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed.floating charge the whole of the company's property,assets,rights and revenues whatsoever and wheresoever present and future including the uncalled share capital (if any).
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 14 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of charge
    Creato il 24 feb 1997
    Consegnato il 14 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or prestigic holdings limited and holaw (332) limited to the chargee (as trustee) or any lender (as defined)
    Brevi particolari
    All the rights, titles benefits and interests and whether present or future of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational leases in respect of units 2 & 3 burrington way plymouth ("the leases/s") other than the sums due to the company by way of insurance rent or service charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 14 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and further legal charge
    Creato il 08 ago 1994
    Consegnato il 11 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £187,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the legal charge and £10,000 (being part of the principal sum detailed above) due under the floating charge
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 7 high street market drayton shropshire t/no sl 53053 all that f/h property k/a the marsh goose (fromerly sheridans restaurant ) high street moreton in marsh t/no GR98033. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint venture agreement
    Creato il 05 ago 1994
    Consegnato il 10 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £26,750.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that f/h premises k/a 6-7 high street market drayton t/no SL53053. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Daywatch Limited
    Transazioni
    • 10 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint venture agreement
    Creato il 05 ago 1994
    Consegnato il 10 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £34,750.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 2-4 albert road widnes cheshire t/no ch 339908. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Daywatch Limited
    Transazioni
    • 10 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and floating charge
    Creato il 06 apr 1994
    Consegnato il 09 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £262,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 328 and 330 chepstow road newport gwent t/no WA236678. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and floating charge
    Creato il 06 apr 1994
    Consegnato il 09 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £262,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 2 and 4 albert road widnes halton cheshire t/no CH339908. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and floating charge
    Creato il 06 apr 1994
    Consegnato il 09 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £262,500.00 and all other monies due or to beocme due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 3/4/vaughan parade and 3 palk street torquay devon t/no DN301207. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint venture agreement
    Creato il 03 mar 1994
    Consegnato il 10 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £67,500.00 together with all other monies due or to become due from the comapny to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    By way of charge l/h vaughan parade and palk street torquay t/no DN301207. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Daywatch Limited
    Transazioni
    • 10 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint venture agreement
    Creato il 03 mar 1994
    Consegnato il 10 mar 1994
    In corso
    Importo garantito
    £82,500.00 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    By way of charge f/h white cloth hall 27 crown street leeds t/no wyk 193950. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Daywatch Limited
    Transazioni
    • 10 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Joint venture agreement
    Creato il 03 mar 1994
    Consegnato il 10 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £36,500.00 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    By way of charge the f/h 328/330 chepstow road newport gwent t/no wa 236678. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Daywatch Limited
    Transazioni
    • 10 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint venture agreement
    Creato il 03 mar 1994
    Consegnato il 10 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17,400.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    By way of charge l/h 1 & 2 rosebery court rosebery avenue london EC1 t/no ngl 704562. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Daywatch Limited
    Transazioni
    • 10 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint venture agreement
    Creato il 03 mar 1994
    Consegnato il 10 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £38,125.00 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    By way of a charge over l/h units 2 & 3 burrington way honicknowle plymouth devon t/no dn 323936. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Daywatch Limited
    Transazioni
    • 10 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint venture agreement
    Creato il 03 mar 1994
    Consegnato il 10 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £32,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the joint venture agreement
    Brevi particolari
    F/H-the marsh goose retaurant (formerly sheridans restaurant) high street moreton-in-marsh cotswold gloucestershire t/n-GR98033.
    Persone aventi diritto
    • Daywatch Limited
    Transazioni
    • 10 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1994
    Consegnato il 11 feb 1994
    In corso
    Importo garantito
    £570,000 and all other moneys due or to become due from the company to allied dunbar assurance PLC, under the terms of the charge,
    Brevi particolari
    Leasehold property known as or being 3-4 vaughan parade and 3 palk street,torquay, devon, first floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC,
    Transazioni
    • 11 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1994
    Consegnato il 11 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £570,000 and all other moneys due or to become due from the company to allied dunbar assurance PLC, under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that freehold property known as or being 328 and 330 chepstow road, newport,gwent, first floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC,
    Transazioni
    • 11 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and floating charge
    Creato il 07 gen 1994
    Consegnato il 13 gen 1994
    In corso
    Importo garantito
    £505,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that f/h propertry k/a the cloth hall 27 crown street leeds t/no wyk 193950 together with A. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 25 ott 1993
    Consegnato il 08 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The f/h land and buildings k/a the marsh goose restaurant high street moreton in marsh gloucestershire t/no gr 98033. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 11 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £168,000 and all other monies due
    Brevi particolari
    L/H 1& 2 rosebery court rosebery avenue london t/n ngl 616980. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 11 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £220,500 and all other monies due
    Brevi particolari
    L/H units 2 & 3 burrington way honicknowle plymouth devon t/n dn 202321. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0