TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02758710 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED?
- Attività di gestione delle strutture informatiche (62030) / Informazione e comunicazione
Dove si trova TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit 2 Quadrant Court Crossways Business Park DA9 9AY Greenhithe Dartford England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| IDE GROUP MANAGE LIMITED | 30 nov 2017 | 30 nov 2017 |
| CORETX MANAGE LIMITED | 11 apr 2016 | 11 apr 2016 |
| SELECTION SERVICES LIMITED | 25 gen 2010 | 25 gen 2010 |
| SELECTION SERVICES PUBLIC LIMITED COMPANY | 16 nov 1992 | 16 nov 1992 |
| SHOWFORM LIMITED | 26 ott 1992 | 26 ott 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 03 ott 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 17 ott 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 03 ott 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Andrew Ian Smith come amministratore in data 30 gen 2026 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Ian Smith il 01 ott 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 45 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David Niall O'regan come amministratore in data 27 mar 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicolas Norman Bedford come amministratore in data 01 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew George Parker come amministratore in data 10 set 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 36 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 027587100012, creata il 09 set 2024 | 53 pagine | MR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 46 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicolas Norman Bedford il 13 dic 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Seconda presentazione della Dichiarazione di conformità datata 03 ott 2023 | 3 pagine | RP04CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Ide Group Financing Limited come persona con controllo significativo il 17 gen 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2023 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew George Parker il 27 giu 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 41 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 027587100011 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Nicolas Norman Bedford come amministratore in data 03 gen 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ms Nicola Catherine Chown come amministratore in data 03 gen 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew George Parker il 15 nov 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed ide group manage LIMITED\certificate issued on 17/11/22 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 41 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOWN, Nicola Catherine | Amministratore | Quadrant Court Crossways Business Park DA9 9AY Greenhithe Unit 2 Dartford England | England | British | 165586980001 | |||||
| O'REGAN, David Niall | Amministratore | Quadrant Court Crossways Business Park DA9 9AY Greenhithe Unit 2 Dartford England | England | Irish | 334224820001 | |||||
| CANTWELL, Alan John | Segretario | 128 Barnfield Wood Road Park Langley BR3 2SX Beckenham Kent | British | 32489380001 | ||||||
| DOWNER, Harvey Paul | Segretario | Provident House 122 High Street BR1 1EZ Bromley Kent | British | 58175620002 | ||||||
| MOORE, Debbie | Segretario nominato | 71 Pitcairn House St Thomas's Square E9 6PU Hackney London | British | 900007470001 | ||||||
| PHIPPS, Julian Gerard Powell | Segretario | 81-85 Station Road CR0 2RD Croydon Interchange United Kingdom | 204813900001 | |||||||
| WOODALL, Mark | Segretario | 44 Masons Hill BR2 9JG Bromley Rutland House England | 179769700001 | |||||||
| BEDFORD, Nicolas Norman | Amministratore | Quadrant Court Crossways Business Park DA9 9AY Greenhithe Unit 2 Dartford England | England | British | 224947200002 | |||||
| BROWN, Kevin Thomas | Amministratore delegato nominato | 30 Harts Grove IG8 0BN Woodford Green Essex | England | British | 900008020001 | |||||
| CANTWELL, Alan John | Amministratore | Brambles Wood Way BR6 8LS Farnborough Park Kent | United Kingdom | British | 32489380002 | |||||
| CLARK, Paul | Amministratore | 44 Masons Hill BR2 9JG Bromley Rutland House England | Great Britain | British | 180066500001 | |||||
| DOBBIE, William | Amministratore | Riseley Business Park Riseley RG7 1NW Reading Napoleon House United Kingdom | Scotland | British | 107339410001 | |||||
| DOWNER, Harvey Paul | Amministratore | Provident House 122 High Street BR1 1EZ Bromley Kent | England | British | 58175620002 | |||||
| FENN, Steven Paul | Amministratore | Orchard Warren Drive KT20 6PZ Kingswood Surrey | United Kingdom | British | 76438630002 | |||||
| HAMILTON-MARTIN, Justin Dax Sebastian | Amministratore | Provident House 122 High Street BR1 1EZ Bromley Kent | England | British | 67115590004 | |||||
| HARRINGTON, Grahame | Amministratore | 44 Masons Hill BR2 9JG Bromley Rutland House England | United Kingdom | British | 59631890003 | |||||
| HUGHES, Christopher John | Amministratore | Provident House 122 High Street BR1 1EZ Bromley Kent | United Kingdom | British | 117518260001 | |||||
| OFFORD, Philip | Amministratore | 44 Masons Hill BR2 9JG Bromley Rutland House England | United Kingdom | British | 188922400001 | |||||
| PARKER, Andrew George | Amministratore | Quadrant Court Crossways Business Park DA9 9AY Greenhithe Unit 2 Dartford England | England | British | 251994320004 | |||||
| PHIPPS, Julian Gerard Powell | Amministratore | 81-85 Station Road CR0 2RD Croydon Interchange United Kingdom | United Kingdom | British | 204757520001 | |||||
| PURI, Harkrishen | Amministratore | 10 Redvers Road CR6 9HN Warlingham Surrey | England | British | 77457910002 | |||||
| ROBINSON, Colin | Amministratore | Provident House 122 High Street BR1 1EZ Bromley Kent | United Kingdom | British | 97946030001 | |||||
| ROSS, Andrew Robert Craig | Amministratore | 81-85 Station Road CR0 2RD Croydon Interchange United Kingdom | England | British | 188497580001 | |||||
| ROWBOTHAM, Joseph Martin | Amministratore | 44 Masons Hill BR2 9JG Bromley Rutland House England | England | British | 97945740001 | |||||
| SMITH, Andrew Ian | Amministratore | Quadrant Court Crossways Business Park DA9 9AY Greenhithe Unit 2 Dartford England | England | British | 286875830002 | |||||
| STRANNER, Charlotte Alexandra | Amministratore | Quadrant Court Crossways Business Park DA9 9AY Greenhithe Unit 2 Dartford England | England | British | 250024630001 | |||||
| TEMPLEMAN, David George | Amministratore | Quadrant Court Crossways Business Park DA9 9AY Greenhithe Unit 2 Dartford England | England | British | 139990750001 | |||||
| WHITE, Vincent John | Amministratore | Provident House 122 High Street BR1 1EZ Bromley Kent | United Kingdom | British | 97945540002 | |||||
| WOODALL, Mark James | Amministratore | 44 Masons Hill BR2 9JG Bromley Rutland House England | England | British | 109282810001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TIALIS ESSENTIAL IT MANAGE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tialis Essential It Financing Limited | 06 apr 2016 | Crossways Business Park Greenhithe DA9 9AY Dartford Unit 2, Quadrant Court Kent England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0