SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED

SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSONIC SOFTWARE (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02759702
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o STEPHEN FABERMAN
    3 Arlington Square
    3rd Floor Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EXCELON UK LIMITED03 feb 200003 feb 2000
    OBJECT DESIGN (UK) LIMITED22 dic 199222 dic 1992
    LAWGRA (NO.176) LIMITED28 ott 199228 ott 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 12 ago 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 28 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 28 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Nomina di Stephen Howard Faberman come amministratore in data 19 ott 2012

    3 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Stephen Howard Faberman il 30 set 2012

    3 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 28 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Cessazione della carica di David H. Benton, Jr. come amministratore in data 14 ott 2011

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 nov 2012

    1 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 nov 2011

    1 pagineAA

    Domanda di ripristino amministrativo

    3 pagineRT01

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio redatto al 30 nov 2010

    7 pagineAA

    Nomina di Mr. David H. Benton come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 210 Bath Road Slough Berkshire SL1 3XE in data 22 ago 2011

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr. Brian Flanagan come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Norman Roberton come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 28 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 nov 2009

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FABERMAN, Stephen Howard
    c/o Stephen Faberman
    Arlington Square
    3rd Floor Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    3
    Berkshire
    England
    Segretario
    c/o Stephen Faberman
    Arlington Square
    3rd Floor Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    3
    Berkshire
    England
    135237480001
    FABERMAN, Stephen Howard, Mr.
    c/o Stephen Faberman
    Arlington Square
    3rd Floor Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    3
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Stephen Faberman
    Arlington Square
    3rd Floor Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    3
    Berkshire
    England
    United StatesAmerican173076760001
    FLANAGAN, Brian, Mr.
    c/o Stephen Faberman
    Arlington Square
    3rd Floor Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    3
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Stephen Faberman
    Arlington Square
    3rd Floor Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    3
    Berkshire
    England
    United StatesAmerican162476600001
    PONGENNARI, Janet Lesley
    18 Albany Park Road
    KT22 7PA Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    18 Albany Park Road
    KT22 7PA Leatherhead
    Surrey
    British115254840001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Segretario nominato
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    ALLEN, Timothy James
    4 Fieldstone Way
    North Reading
    Massachusetts
    01864
    Usa
    Amministratore
    4 Fieldstone Way
    North Reading
    Massachusetts
    01864
    Usa
    American55428170001
    BEAGLE, James Malcolm
    105e Slough Road
    Datchet
    SL3 9AQ Slough
    Amministratore
    105e Slough Road
    Datchet
    SL3 9AQ Slough
    British69363450004
    BENTON, JR., David H., Mr.
    c/o Stephen Faberman
    Arlington Square
    3rd Floor Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    3
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Stephen Faberman
    Arlington Square
    3rd Floor Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    3
    Berkshire
    England
    UsaAmerican162354200001
    BRANDT, Lacey
    7 Alhambra Road
    USA Wellesley
    Massachusetts 02181
    Amministratore
    7 Alhambra Road
    USA Wellesley
    Massachusetts 02181
    American51034850001
    MARSHALL, Kenneth Edward
    17 Kress Farm Road
    Hingham
    Massachusetts
    02043
    Usa
    Amministratore
    17 Kress Farm Road
    Hingham
    Massachusetts
    02043
    Usa
    American69145710001
    O'CONNOR, Gregory Joseph
    20 Chattam Road
    Andover
    Ma 01810
    Usa
    Amministratore
    20 Chattam Road
    Andover
    Ma 01810
    Usa
    Amercian87316510001
    PERREAULT, Justin James
    295 Beacon Street 32
    Boston
    Massachusetts 02116
    Usa
    Amministratore
    295 Beacon Street 32
    Boston
    Massachusetts 02116
    Usa
    American51034830001
    POTTER, Robert Joseph
    79 Woodside Road
    Winchester
    Massachusetts 01890
    Usa
    Amministratore
    79 Woodside Road
    Winchester
    Massachusetts 01890
    Usa
    Us National32489000001
    ROBERTON, Norman Roy
    179 Main Street
    Groton
    Ma 01450
    Usa
    Amministratore
    179 Main Street
    Groton
    Ma 01450
    Usa
    UsaUnited States87316460002
    SANDEEN, Mark Douglas
    2 Liberty Avenue
    Lexington
    Massachusetts 02173
    Usa
    Amministratore
    2 Liberty Avenue
    Lexington
    Massachusetts 02173
    Usa
    Us Citizen32489010001
    TURNER, Nicholas Spencer
    Flat 6 53 Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5QP London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 6 53 Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5QP London
    British900005470001

    SONIC SOFTWARE (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 03 mag 2002
    Consegnato il 10 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's interest in and to the account being a separate designated interest bearing account opened or to be opened by the company (as chargee) in it's name with the royal bank of scotland (or any other bank as the chargee shall decide) into which the deposit (being an amount equal to one half of the rent which at the date of the deed is £67,681.53) is from time to time paid pursuant to the deed and all monies (including interest and other accruals) standing to the credit of such account.
    Persone aventi diritto
    • Nsb Retail Systems PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rental deposit deed
    Creato il 26 ott 1995
    Consegnato il 13 nov 1995
    In corso
    Importo garantito
    £64,000 and all other monies due or to become due from the company and/or ilog limited to the chargee under the terms of a lease dated 26TH october 1995
    Brevi particolari
    All sums of money which have been or are now or which may at any time or from time to time be deposited with the chargee to maintain the rental deposit in an amount equal to sixty-four thousand pounds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cpp Bracknell Limitedacting by J.F.Soden and M.C.Batten
    Transazioni
    • 13 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0