LEGACY COMPANY THREE LTD.

LEGACY COMPANY THREE LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEGACY COMPANY THREE LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02760037
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEGACY COMPANY THREE LTD.?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova LEGACY COMPANY THREE LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    Cheshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEGACY COMPANY THREE LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DEDICATED MICROS LIMITED29 mar 199329 mar 1993
    NORTH CENTRAL CENTRAL SERVICES LIMITED29 ott 199229 ott 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEGACY COMPANY THREE LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LEGACY COMPANY THREE LTD.?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LEGACY COMPANY THREE LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Nomina di Mr Michael James Newton come amministratore in data 31 mag 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Pauline Anne Norstrom come amministratore in data 18 apr 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie come amministratore in data 17 apr 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Helen Pamela Doroszkiewicz come segretario in data 17 apr 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1200 Daresbury Park Daresbury Warrington WA4 4HS a No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB in data 12 mar 2016

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2015 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 dic 2015

    Stato del capitale al 21 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2014

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 nov 2014

    Stato del capitale al 26 nov 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2013

    3 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed dedicated micros LIMITED\certificate issued on 11/03/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name11 mar 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 11 mar 2014

    RES15
    change-of-name11 mar 2014

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 ott 2013

    Stato del capitale al 30 ott 2013

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie il 24 ott 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mrs Helen Pamela Doroszkiewicz come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di LEGACY COMPANY THREE LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEWTON, Michael James
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritish24712770003
    BANNISTER, Stephen David
    Cock Lane Farm
    Warrington Road, Great Budworth
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    Segretario
    Cock Lane Farm
    Warrington Road, Great Budworth
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    British67739860001
    BENTLEY-BUCHANAN, Sarah
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    British135492410001
    DOROSZKIEWICZ, Helen Pamela
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Segretario
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    164871050001
    JOHNSON, Karen Louise
    18 Colwyn Road
    Bramhall
    SK7 2JQ Stockport
    Cheshire
    Segretario
    18 Colwyn Road
    Bramhall
    SK7 2JQ Stockport
    Cheshire
    British60983560001
    SPROTT, David
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    Segretario
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    British106628420001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BANNISTER, Stephen David
    Cock Lane Farm
    Warrington Road, Great Budworth
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Cock Lane Farm
    Warrington Road, Great Budworth
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    British67739860001
    BARLOW, James
    15 Aspenwood Close
    Marple
    SK6 6NU Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    15 Aspenwood Close
    Marple
    SK6 6NU Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish21095060001
    CLAYTON JONES, Andrea Jayne
    1 Venables Way
    High Lea
    WA16 6LY Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    1 Venables Way
    High Lea
    WA16 6LY Knutsford
    Cheshire
    British15214320001
    DRENT, Ivo
    Korbeeklosestraat 16
    Bierbeek 3360
    FOREIGN Belgium
    Amministratore
    Korbeeklosestraat 16
    Bierbeek 3360
    FOREIGN Belgium
    Belgian58744920001
    DUSARA, Paresh Devchand
    Park Cottage
    Wrenshot Lane, High Legh
    WA16 6PG Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Park Cottage
    Wrenshot Lane, High Legh
    WA16 6PG Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritish64177820001
    ELLIOTT, John Martyn
    8 Spindlepoint Drive
    Worsley
    M28 7GL Manchester
    Amministratore
    8 Spindlepoint Drive
    Worsley
    M28 7GL Manchester
    British56423870001
    FAWCETT, Michael Alan
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    Amministratore
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    British38913590002
    FINN, Andrew Patrick
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish169499300001
    HUMPHREY, John Eugene
    23 Whitland Avenue
    BL1 5FB Bolton
    Greater Manchester
    Amministratore
    23 Whitland Avenue
    BL1 5FB Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritish119278130001
    KULLESEID, Peter James
    9 Rooklands Scotter
    DN21 3TT Gainsborough
    Lincolnshire
    Amministratore
    9 Rooklands Scotter
    DN21 3TT Gainsborough
    Lincolnshire
    British56139320001
    NEWTON, Michael James
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6JB Nortwich
    Cheshire
    Amministratore
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6JB Nortwich
    Cheshire
    EnglandBritish24712770003
    NORSTROM, Pauline Anne
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritish148506110001
    O'DOWD, Christopher John
    Rathbane
    Princes Gate
    HX3 0EH Halifax
    Yorkshire
    Amministratore
    Rathbane
    Princes Gate
    HX3 0EH Halifax
    Yorkshire
    EnglandIrish92850910001
    OLIVER, Graeme William
    7 Burnside
    Shaw
    OL2 8LE Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    7 Burnside
    Shaw
    OL2 8LE Oldham
    Lancashire
    British3382660001
    PETRIE, Nigel Fredrick Thomas Hugh
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish51578980003
    RYAN, Mark Stephen Edward
    2 Redington Close
    Worsley
    M28 1UJ Manchester
    Amministratore
    2 Redington Close
    Worsley
    M28 1UJ Manchester
    British61915760002
    SPENCER, Kathryn Margaret
    The Hollies Browns Lane
    SK9 2BR Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    The Hollies Browns Lane
    SK9 2BR Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish58744980001
    SPROTT, David
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    Amministratore
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    British106628420001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    LEGACY COMPANY THREE LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 17 dic 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents (as defined in the debenture) and/or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mar 1995
    Consegnato il 16 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 giu 1994
    Consegnato il 01 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0