GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED

GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02762842
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KEEPEAGER LIMITED09 nov 199209 nov 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP in data 23 ott 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 ott 2015

    Stato del capitale al 23 ott 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 15 dic 2014

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ott 2014

    Stato del capitale al 20 ott 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Elizabeth Catchpole come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Jon William Mortimore come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ott 2013

    Stato del capitale al 18 ott 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Segretario
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147807760001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    TAYLOR, David John
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    Segretario
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    British136521790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, David Charles
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    Amministratore
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    BritishDirector35117370001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Amministratore
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritishDirector62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    Amministratore
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    EnglandBritishSecretary98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MARSHALL, Louis Daniel
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    Amministratore
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director152847400001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritishCfo207729000002
    NESBITT, Peter Victor
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    Amministratore
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    BritishDirector27564990001
    PEDLEY, Mark Jonathan
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    BritishSales Director112119110001
    WEST, William Samuel
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    BritishCompany Director35383900001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 09 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 lug 2000
    Consegnato il 27 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1998
    Consegnato il 23 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a pymore bridport in the county of dorset t/n DT202773, DT207080, DT229615 & DT207062. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    First party commercial legal charge
    Creato il 17 set 1996
    Consegnato il 20 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H little hamonds farm london road burgess hill east sussex t/no SX116439 fixed charge all buildings and other structures fixed charge asigns of goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1995
    Consegnato il 08 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a moorfields mill lane south holmwood surrey t/n SY599533, allbuildings structures items plant and machinery, goodwill, rentals claims under insurance policies relating or fixed to the property, floating charge over unattached plant machinery chattels and goods in connection with the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of life policy
    Creato il 26 set 1995
    Consegnato il 11 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Lloyd's life policy no 551/N3AA079 together with all rights, title, interests and accreations thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 07 set 1995
    Consegnato il 20 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    58 maywater close sanderstead surrey t/no: TGL304052. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 ago 1995
    Consegnato il 29 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a 5 and 5A hawthorne place and 9 linden place epsom surrey t/n's SY643611,SY364122 and SY80306. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Life policy assignation
    Creato il 20 mag 1994
    Consegnato il 02 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Lloyds underwriters :cygnet life policy no.:risk no.N3AAO79 together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 07 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 07 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a santa tecla stanstead caterham surrey t/n SY399840. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0