OLDHAM LIGHTING LIMITED

OLDHAM LIGHTING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOLDHAM LIGHTING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02765114
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OLDHAM LIGHTING LIMITED?

    • (3162) /
    • (5261) /

    Dove si trova OLDHAM LIGHTING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Claudgen House Eastwick Road
    Bookham
    KT23 4DT Leatherhead
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OLDHAM LIGHTING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MATAHARI 474 LIMITED17 nov 199217 nov 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di OLDHAM LIGHTING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per OLDHAM LIGHTING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 09 mar 2012

    9 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 13 set 2011

    9 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 13 mar 2011

    14 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    26 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    8 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da Claudgen House Eastwick Road Great Bookham Surrey KT23 4DT in data 29 set 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 nov 2009

    Stato del capitale al 18 nov 2009

    • Capitale: GBP 220,666.5
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Paul Richardson il 18 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Beatrice Sarraf Cordelle il 18 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per John Martin il 18 nov 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2008

    9 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    8 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return10 apr 2008

    legacy

    363(288)

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2006

    7 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2005

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    9 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di OLDHAM LIGHTING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, John
    Hoe Lane
    Flansham
    PO22 8NU Bognor Regis
    Old Tiles
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Hoe Lane
    Flansham
    PO22 8NU Bognor Regis
    Old Tiles
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishSales Director102008010003
    RICHARDSON, Christopher Paul
    The Lair
    24 Quarry Gardens
    KT22 8UE Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    The Lair
    24 Quarry Gardens
    KT22 8UE Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishGeneral Manager32136440003
    SARRAF CORDELLE, Beatrice
    5 Av De La Cigale
    Asnieres
    92600
    France
    Amministratore
    5 Av De La Cigale
    Asnieres
    92600
    France
    FranceFrenchDirector102008180001
    BROWN, Anthony James
    84 Lyncroft Mansions
    Lyncroft Gardens
    NW6 1JY West Hampstead
    London
    Segretario
    84 Lyncroft Mansions
    Lyncroft Gardens
    NW6 1JY West Hampstead
    London
    United KingdomCompany Secretary72256810001
    BYLES, Debra Ann
    59a Whitford Gardens
    CR4 4AB Mitcham
    Surrey
    Segretario
    59a Whitford Gardens
    CR4 4AB Mitcham
    Surrey
    British38459310001
    FINNERAN, Adrian Patrick
    Cornerways 8 The Kingsway
    Ewell Village
    KT17 1LT Epsom
    Surrey
    Segretario
    Cornerways 8 The Kingsway
    Ewell Village
    KT17 1LT Epsom
    Surrey
    Irish49205900001
    HERD, Peter James
    40 Blenheim Gardens
    HA9 7NP Wembley
    Middlesex
    Segretario
    40 Blenheim Gardens
    HA9 7NP Wembley
    Middlesex
    BritishFinancial Controller32136410001
    MCLOUGHLIN, Eileen Claire
    16 Willow Gardens
    HA4 6JT Ruislip
    Middlesex
    Segretario
    16 Willow Gardens
    HA4 6JT Ruislip
    Middlesex
    British32136420001
    SUKUMARAN, Ratnapragasam
    Cherry Blossom 11 Downs Hill Road
    KT18 5HW Epsom
    Surrey
    Segretario
    Cherry Blossom 11 Downs Hill Road
    KT18 5HW Epsom
    Surrey
    British58963240001
    TKB REGISTRARS LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Segretario nominato
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900002650001
    BROWN, Anthony James
    84 Lyncroft Mansions
    Lyncroft Gardens
    NW6 1JY West Hampstead
    London
    Amministratore
    84 Lyncroft Mansions
    Lyncroft Gardens
    NW6 1JY West Hampstead
    London
    United KingdomUnited KingdomFinancial Director72256810001
    HERD, Peter James
    40 Blenheim Gardens
    HA9 7NP Wembley
    Middlesex
    Amministratore
    40 Blenheim Gardens
    HA9 7NP Wembley
    Middlesex
    BritishFinancial Controller32136410001
    MCKAY, Michael William Hoy
    Peggs Farm
    Orton On The Hill
    CV9 3NE Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    Peggs Farm
    Orton On The Hill
    CV9 3NE Atherstone
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector53050860001
    ROBINSON, David Foster
    Luards
    Langford
    CM9 6QB Maldon
    Essex
    Amministratore
    Luards
    Langford
    CM9 6QB Maldon
    Essex
    BritishChartered Accountant13465400001
    ROPER, Mervyn Edward Patrick
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Amministratore delegato nominato
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    British900002640001
    TREVILLION, Anthony Paul
    7 Saxon Road
    Worth
    RH10 7SA Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    7 Saxon Road
    Worth
    RH10 7SA Crawley
    West Sussex
    EnglandBritishMarketing/Commercial Manager41005500001
    WOOD, Raymond Edward
    8 Epsom Lane North
    KT20 5EH Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    8 Epsom Lane North
    KT20 5EH Tadworth
    Surrey
    BritishProprietor32136430001

    OLDHAM LIGHTING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 05 set 2001
    Consegnato il 13 set 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rental deposit deed
    Creato il 24 nov 2000
    Consegnato il 07 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    £8,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit sum is £8,000.00.
    Persone aventi diritto
    • Mr Raymond Jenner
    Transazioni
    • 07 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 feb 1999
    Consegnato il 09 mar 1999
    In corso
    Importo garantito
    The obligations of the tenant to pay the rents under the terms of the lease
    Brevi particolari
    £2,244 plus vat.
    Persone aventi diritto
    • Barlows PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 dic 1998
    Consegnato il 18 dic 1998
    In corso
    Importo garantito
    The company's obligations to the chargee under a lease dated 16TH december 1998 and the rent deposit deed
    Brevi particolari
    The sum of £7,338.
    Persone aventi diritto
    • Slough Properties Limited
    Transazioni
    • 18 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 giu 1998
    Consegnato il 17 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Baronsmead Investment Trust PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 16 feb 1995
    Consegnato il 01 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from guinness flight and calder S.A.R.L. the trustees of the oldham lighting limited share ownership plan to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re oldham lighting limited group current account account number 40299766. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 dic 1992
    Consegnato il 17 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OLDHAM LIGHTING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 mar 2012Fine dell'amministrazione
    14 set 2010Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy James Heaselgrave
    Redfern House 29 Jury Street
    CV34 4EH Warwick
    Praticante
    Redfern House 29 Jury Street
    CV34 4EH Warwick

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0