MEP SOLUTIONS LIMITED

MEP SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMEP SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02769705
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MEP SOLUTIONS LIMITED?

    • fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o DELOITTE LLP
    Four
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    A-BELCO LIMITED12 ott 200112 ott 2001
    BALS ENGINEERING GROUP LIMITED20 ago 199320 ago 1993
    COPYLIMIT LIMITED01 dic 199201 dic 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    19 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    41 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    41 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    8 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da Deloitte Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ a C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ in data 10 nov 2016

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Jubilee Industrial Estate Ashington Northumberland NE63 8UG a Deloitte Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ in data 02 nov 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Iscrizione dell'ipoteca 027697050012, creata il 21 giu 2016

    39 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2016

    Stato del capitale al 07 apr 2016

    • Capitale: GBP 305,010.1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    17 pagineAA

    Nomina di Mr Kevin Robert Wills come amministratore in data 03 nov 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Linda Billings come amministratore in data 30 apr 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 apr 2015

    Stato del capitale al 29 apr 2015

    • Capitale: GBP 305,010.1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    17 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 027697050011

    32 pagineMR01
    Note
    DataNota
    05 giu 2014The electronic copy of the certified copy instrument associated with this transaction contains some elements which may not be legible. This is a result of a loss of definition in our image-conversion process. If you would like to view a copy of the instrument as presented to the registrar, please call 02920 381367.

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mag 2014

    Stato del capitale al 09 mag 2014

    • Capitale: GBP 305,010.1
    SH01

    Stato del capitale al 14 mar 2014

    • Capitale: GBP 305,010.1
    5 pagineSH19

    Iscrizione dell'ipoteca 027697050010

    33 pagineMR01

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Chi sono gli amministratori di MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TRENCH, Brian Irving
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Segretario
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    152515670001
    TRENCH, Brian Irving
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Amministratore
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    United KingdomBritish110877740001
    WILLS, Kevin Robert
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Amministratore
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    EnglandBritish106492050001
    ALLAN, Peter Riddle
    Valley View
    Iveston Lane
    DH8 7TD Consett
    County Durham
    Segretario
    Valley View
    Iveston Lane
    DH8 7TD Consett
    County Durham
    British35573440002
    JACKSON, Stephen
    39 Highside Drive
    Humbledon Hill
    SR3 1UL Sunderland
    Tyne & Wear
    Segretario
    39 Highside Drive
    Humbledon Hill
    SR3 1UL Sunderland
    Tyne & Wear
    British36996160001
    KELLY, Michael John
    Threeways
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    Segretario
    Threeways
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    British36411030002
    KETCHIN, John Scott
    65 Cheviot View
    Ponteland
    NE20 9BH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    65 Cheviot View
    Ponteland
    NE20 9BH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British19040640001
    WATSON, Alan Roy
    5 Thornlea
    NE61 6NY Hepscott
    Northumberland
    Segretario
    5 Thornlea
    NE61 6NY Hepscott
    Northumberland
    British93102570001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Segretario nominato
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    BALS, Gunter
    Burgweg 23
    Kirchhumden 57399
    Germany
    Amministratore
    Burgweg 23
    Kirchhumden 57399
    Germany
    German39717660002
    BEGBIE, Roderick Mcintosh
    17/1 St Leonards Lane
    EH8 9SD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    17/1 St Leonards Lane
    EH8 9SD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British54412390001
    BILLINGS, Linda
    Jubilee Industrial Estate
    Ashington
    NE63 8UG Northumberland
    Amministratore
    Jubilee Industrial Estate
    Ashington
    NE63 8UG Northumberland
    EnglandIrish111924870001
    BROWN, Colin Martin
    Churchburn Drive
    Loansdean
    NE61 2BZ Morpeth
    48
    Northumberland
    Amministratore
    Churchburn Drive
    Loansdean
    NE61 2BZ Morpeth
    48
    Northumberland
    United KingdomBritish131092030001
    DUFFY, Frank Thomas
    6 South View
    Hepscott Park Stannington
    NE61 6NG Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    6 South View
    Hepscott Park Stannington
    NE61 6NG Morpeth
    Northumberland
    British36030990001
    DYER, Ian
    13 Hareside
    Whitelea Glade
    NE23 6BH Cramlington
    Northumberland
    Amministratore
    13 Hareside
    Whitelea Glade
    NE23 6BH Cramlington
    Northumberland
    United KingdomBritish39072930001
    GIBSON, John
    72 Heron Drive
    Sandal
    WF2 6SP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    72 Heron Drive
    Sandal
    WF2 6SP Wakefield
    West Yorkshire
    British37005950001
    HANDS, Stephen Christopher
    Flat 24 Tower House
    Tower Street
    NE1 2HW Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Flat 24 Tower House
    Tower Street
    NE1 2HW Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British66910630002
    HUGHES, Robert Charles
    15 Hawkshead Drive
    B93 9QE Knowle
    West Midlands
    Amministratore
    15 Hawkshead Drive
    B93 9QE Knowle
    West Midlands
    British84757480002
    JACKSON, Stephen
    39 Highside Drive
    Humbledon Hill
    SR3 1UL Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    39 Highside Drive
    Humbledon Hill
    SR3 1UL Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish36996160001
    JASAT, Azim
    3 Greenwood Close
    B14 6ET Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    3 Greenwood Close
    B14 6ET Birmingham
    West Midlands
    British107438550001
    KELLY, Michael John
    Threeways
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Threeways
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish36411030002
    KETCHIN, John Scott
    65 Cheviot View
    Ponteland
    NE20 9BH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    65 Cheviot View
    Ponteland
    NE20 9BH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish19040640001
    METCALF, Edward Alexander
    Oldfield House 11 Station Close
    NE44 6HE Riding Mill
    Northumberland
    Amministratore
    Oldfield House 11 Station Close
    NE44 6HE Riding Mill
    Northumberland
    British31125570001
    MURRAY, Kenneth Roderick
    42 St Andrews Square
    EH2 2AD Edinburgh
    Amministratore
    42 St Andrews Square
    EH2 2AD Edinburgh
    British43513870003
    POWELL, Robert
    Derry Jane House
    Stocks Hill Belton
    DN9 1PE Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Derry Jane House
    Stocks Hill Belton
    DN9 1PE Doncaster
    South Yorkshire
    British37005880002
    SCHOLEY, Derek
    228 Oakwood Lane
    LS8 2PE Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    228 Oakwood Lane
    LS8 2PE Leeds
    Yorkshire
    British23788760001
    SKUCHA, Nicholas Paul
    5 The Elms
    Porthill
    ST5 8RP Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    5 The Elms
    Porthill
    ST5 8RP Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    United KingdomBritish117468110001
    WATSON, Alan Roy
    5 Thornlea
    NE61 6NY Hepscott
    Northumberland
    Amministratore
    5 Thornlea
    NE61 6NY Hepscott
    Northumberland
    EnglandBritish93102570001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    MEP SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 21 giu 2016
    Consegnato il 28 giu 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 28 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 mag 2014
    Consegnato il 04 giu 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 mar 2014
    Consegnato il 08 mar 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 16 apr 2010
    Consegnato il 17 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 28 nov 2005
    Consegnato il 30 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Deposit of £5,728.13.
    Persone aventi diritto
    • Im Properties (Coleshill) Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 30 set 2003
    Consegnato il 07 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 07 ott 2002
    Consegnato il 09 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over cash deposit created by the company (formerly known as bals engineering group limited) in favour of the bank
    Creato il 04 ott 2001
    Consegnato il 13 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the account of the company with bank of scotland which is blocked or designated as charged to bank of scotland now numbered 00136818 as may be replaced redesignated renumbered or rearranged from time to time.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ott 2001
    Consegnato il 09 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities whether principal interest or otherwise which may now or at any time hereafter become due owing or payable by sandco 708 limited and/or bals industrial accessories limited to the chargees as listed in schedule 1 of a loan agreement dated 4 october 2001 and made between the company the security trustees and such lenders ("the loan agreement")
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • D a Scholey, S Jackson, M J Kelly (As Security Trustees).
    Transazioni
    • 09 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignation of keyman policy
    Creato il 25 apr 1997
    Consegnato il 01 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Allied dunbar assurance PLC adaptable term plan, policy number 23036-088-das, date: 1/2/97, sum: £250,000, life assured: michael john kelly together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral secured debenture
    Creato il 07 set 1994
    Consegnato il 16 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from bals industrial accessories limited to the chargee under the terms of a debenture dated 7 september 1994
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • British Coal Enterprise Limited
    Transazioni
    • 16 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 ott 1993
    Consegnato il 30 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MEP SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 ott 2016Inizio dell'amministrazione
    23 ott 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0