MEP SOLUTIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MEP SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02769705 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MEP SOLUTIONS LIMITED?
- fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere
Dove si trova MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o DELOITTE LLP Four Brindley Place B1 2HZ Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| A-BELCO LIMITED | 12 ott 2001 | 12 ott 2001 |
| BALS ENGINEERING GROUP LIMITED | 20 ago 1993 | 20 ago 1993 |
| COPYLIMIT LIMITED | 01 dic 1992 | 01 dic 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione | 19 pagine | AM23 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 19 pagine | AM10 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 20 pagine | AM10 | ||||||||||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 3 pagine | AM19 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 20 pagine | AM10 | ||||||||||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 41 pagine | F2.18 | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 41 pagine | 2.17B | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B | 8 pagine | 2.16B | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Deloitte Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ a C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ in data 10 nov 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Jubilee Industrial Estate Ashington Northumberland NE63 8UG a Deloitte Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ in data 02 nov 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 027697050012, creata il 21 giu 2016 | 39 pagine | MR01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin Robert Wills come amministratore in data 03 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Linda Billings come amministratore in data 30 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 027697050011 | 32 pagine | MR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 14 mar 2014
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 027697050010 | 33 pagine | MR01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENCH, Brian Irving | Segretario | c/o Deloitte Llp Brindley Place B1 2HZ Birmingham Four | 152515670001 | |||||||
| TRENCH, Brian Irving | Amministratore | c/o Deloitte Llp Brindley Place B1 2HZ Birmingham Four | United Kingdom | British | 110877740001 | |||||
| WILLS, Kevin Robert | Amministratore | c/o Deloitte Llp Brindley Place B1 2HZ Birmingham Four | England | British | 106492050001 | |||||
| ALLAN, Peter Riddle | Segretario | Valley View Iveston Lane DH8 7TD Consett County Durham | British | 35573440002 | ||||||
| JACKSON, Stephen | Segretario | 39 Highside Drive Humbledon Hill SR3 1UL Sunderland Tyne & Wear | British | 36996160001 | ||||||
| KELLY, Michael John | Segretario | Threeways Tranwell Woods NE61 6AQ Morpeth Northumberland | British | 36411030002 | ||||||
| KETCHIN, John Scott | Segretario | 65 Cheviot View Ponteland NE20 9BH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 19040640001 | ||||||
| WATSON, Alan Roy | Segretario | 5 Thornlea NE61 6NY Hepscott Northumberland | British | 93102570001 | ||||||
| JL NOMINEES TWO LIMITED | Segretario nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
| BALS, Gunter | Amministratore | Burgweg 23 Kirchhumden 57399 Germany | German | 39717660002 | ||||||
| BEGBIE, Roderick Mcintosh | Amministratore | 17/1 St Leonards Lane EH8 9SD Edinburgh Midlothian Scotland | British | 54412390001 | ||||||
| BILLINGS, Linda | Amministratore | Jubilee Industrial Estate Ashington NE63 8UG Northumberland | England | Irish | 111924870001 | |||||
| BROWN, Colin Martin | Amministratore | Churchburn Drive Loansdean NE61 2BZ Morpeth 48 Northumberland | United Kingdom | British | 131092030001 | |||||
| DUFFY, Frank Thomas | Amministratore | 6 South View Hepscott Park Stannington NE61 6NG Morpeth Northumberland | British | 36030990001 | ||||||
| DYER, Ian | Amministratore | 13 Hareside Whitelea Glade NE23 6BH Cramlington Northumberland | United Kingdom | British | 39072930001 | |||||
| GIBSON, John | Amministratore | 72 Heron Drive Sandal WF2 6SP Wakefield West Yorkshire | British | 37005950001 | ||||||
| HANDS, Stephen Christopher | Amministratore | Flat 24 Tower House Tower Street NE1 2HW Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | 66910630002 | ||||||
| HUGHES, Robert Charles | Amministratore | 15 Hawkshead Drive B93 9QE Knowle West Midlands | British | 84757480002 | ||||||
| JACKSON, Stephen | Amministratore | 39 Highside Drive Humbledon Hill SR3 1UL Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 36996160001 | |||||
| JASAT, Azim | Amministratore | 3 Greenwood Close B14 6ET Birmingham West Midlands | British | 107438550001 | ||||||
| KELLY, Michael John | Amministratore | Threeways Tranwell Woods NE61 6AQ Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | 36411030002 | |||||
| KETCHIN, John Scott | Amministratore | 65 Cheviot View Ponteland NE20 9BH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | 19040640001 | |||||
| METCALF, Edward Alexander | Amministratore | Oldfield House 11 Station Close NE44 6HE Riding Mill Northumberland | British | 31125570001 | ||||||
| MURRAY, Kenneth Roderick | Amministratore | 42 St Andrews Square EH2 2AD Edinburgh | British | 43513870003 | ||||||
| POWELL, Robert | Amministratore | Derry Jane House Stocks Hill Belton DN9 1PE Doncaster South Yorkshire | British | 37005880002 | ||||||
| SCHOLEY, Derek | Amministratore | 228 Oakwood Lane LS8 2PE Leeds Yorkshire | British | 23788760001 | ||||||
| SKUCHA, Nicholas Paul | Amministratore | 5 The Elms Porthill ST5 8RP Newcastle Under Lyme Staffordshire | United Kingdom | British | 117468110001 | |||||
| WATSON, Alan Roy | Amministratore | 5 Thornlea NE61 6NY Hepscott Northumberland | England | British | 93102570001 | |||||
| JL NOMINEES ONE LIMITED | Amministratore delegato nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007210001 |
MEP SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 21 giu 2016 Consegnato il 28 giu 2016 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 mag 2014 Consegnato il 04 giu 2014 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 06 mar 2014 Consegnato il 08 mar 2014 | In corso | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 apr 2010 Consegnato il 17 apr 2010 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 28 nov 2005 Consegnato il 30 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Deposit of £5,728.13. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Creato il 30 set 2003 Consegnato il 07 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 ott 2002 Consegnato il 09 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over cash deposit created by the company (formerly known as bals engineering group limited) in favour of the bank | Creato il 04 ott 2001 Consegnato il 13 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies standing to the credit of the account of the company with bank of scotland which is blocked or designated as charged to bank of scotland now numbered 00136818 as may be replaced redesignated renumbered or rearranged from time to time. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 04 ott 2001 Consegnato il 09 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities whether principal interest or otherwise which may now or at any time hereafter become due owing or payable by sandco 708 limited and/or bals industrial accessories limited to the chargees as listed in schedule 1 of a loan agreement dated 4 october 2001 and made between the company the security trustees and such lenders ("the loan agreement") | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of keyman policy | Creato il 25 apr 1997 Consegnato il 01 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Allied dunbar assurance PLC adaptable term plan, policy number 23036-088-das, date: 1/2/97, sum: £250,000, life assured: michael john kelly together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral secured debenture | Creato il 07 set 1994 Consegnato il 16 set 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from bals industrial accessories limited to the chargee under the terms of a debenture dated 7 september 1994 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 ott 1993 Consegnato il 30 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MEP SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In amministrazione |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0