KIRKHEATON WIND LIMITED

KIRKHEATON WIND LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKIRKHEATON WIND LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02771937
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KIRKHEATON WIND LIMITED?

    • Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

    Dove si trova KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Alexander House 1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    England
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    UK GAS & ELECTRIC LIMITED21 gen 199321 gen 1993
    KILDALE LIMITED08 dic 199208 dic 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Ian Jessop come amministratore in data 01 ago 2023

    2 pagineAP01

    Stato del capitale al 03 lug 2023

    • Capitale: GBP 257
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Laura Katherine Chare come segretario in data 24 nov 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Melanie Shanker come segretario in data 24 nov 2022

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    32 pagineAA

    Nomina di Mr Piero Maggio come amministratore in data 16 mag 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Pierre-Arthur, Maurice, Michel Lestrade come amministratore in data 16 mag 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Pierre-Arthur, Maurice, Michel Lestrade come amministratore in data 22 dic 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthieu Thomas Hue come amministratore in data 22 dic 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    33 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Susan Elizabeth Lind come segretario in data 23 nov 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Laura Katherine Chare come segretario in data 23 nov 2020

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    31 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    29 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHANKER, Melanie
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Segretario
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    303067320001
    JESSOP, Ian
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    ScotlandBritishDirector312208460001
    MAGGIO, Piero
    1 Mandarin Road, Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road, Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    EnglandBritishCompany Director296324960001
    MAJID, Hassaan
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director227170770002
    CHARE, Laura Katherine
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Segretario
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    280497220001
    ELLIOTT, John
    18 Frosterley Drive
    DH3 4SJ Great Lumley
    County Durham
    Segretario
    18 Frosterley Drive
    DH3 4SJ Great Lumley
    County Durham
    British157550030001
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Segretario
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    British108926390001
    HIGSON, Robert Ian
    Springfield
    Calvert Road
    RH4 1LT Dorking
    Surrey
    Segretario
    Springfield
    Calvert Road
    RH4 1LT Dorking
    Surrey
    British61249910002
    KACZOROWSKI, Stephane
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    Segretario
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    187107410001
    LIND, Susan Elizabeth
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Segretario
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    200530650001
    SOUTO, Joe
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Segretario
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    146431380001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Segretario nominato
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    ANCEAU, Geraldine Marie Roseline
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    Amministratore
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    FranceFrenchCompany Director220722130001
    BAKER, David Simon George
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Amministratore
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    United KingdomBritishHead Of Renewable Operations197462530001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    CHANDLER, Malcolm George
    40 Earnshaw Way
    Beaumont Park
    NE25 9UN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    40 Earnshaw Way
    Beaumont Park
    NE25 9UN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishElectrical Engineer32594940001
    CONNOR, Phillip Eric
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    Amministratore
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    EnglandEnglishEngineer72946860001
    CUTTILL, Paul Andrew
    25 Bushey Avenue
    South Woodford
    E18 2DT London
    Amministratore
    25 Bushey Avenue
    South Woodford
    E18 2DT London
    BritishGroup Corporate Services Direc116268290001
    DANIELS, Christopher John
    Mistletoe Cottage
    57 Wickham Hill
    BN6 9NR Hurstpierpoint
    West Sussex
    Amministratore
    Mistletoe Cottage
    57 Wickham Hill
    BN6 9NR Hurstpierpoint
    West Sussex
    BritishChief Operating Officer Ener72808850001
    DIXON, Adrian
    155 Norwich Road
    Wroxham
    NR12 8RZ Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    155 Norwich Road
    Wroxham
    NR12 8RZ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishElectrical Engineer125881320001
    FORSTER, Owen John Henry
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director208859480001
    FORSTER, Owen John Henry
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director208859480001
    GUYLER, Robert
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Amministratore
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    ScotlandBritishAccountant183996210001
    HUE, Matthieu Thomas
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandFrenchCompany Director183883770001
    LARSEN, Bruno Kold
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Amministratore
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    DenmarkDanishArea Director178861250001
    LAWLESS, Philip Stewart, Dr
    Old Courthouse
    Kirkwhelpington
    NE19 2RS Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Old Courthouse
    Kirkwhelpington
    NE19 2RS Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishGeneration Project Manager92885220001
    LAWRENCE, Martin Charles
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer Energy121114690001
    LESTRADE, Pierre-Arthur, Maurice, Michel
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    GreeceFrenchCompany Director276922120001
    LINGE, Kenneth
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    Amministratore
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    EnglandBritishAccountant52698930001
    LORY, Ronan Emmanuel
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Amministratore
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    United KingdomFrenchCompany Director163104520001
    NORMAN, Angus Tindale
    11 Granville Road
    Walmer
    CT14 7LU Deal
    Kent
    Amministratore
    11 Granville Road
    Walmer
    CT14 7LU Deal
    Kent
    BritishChartered Engineer80532370001
    STILL, David John
    Redpath
    Haltwhistle
    NE49 0LG Northumberland
    Ivy Cottage
    England
    England
    Amministratore
    Redpath
    Haltwhistle
    NE49 0LG Northumberland
    Ivy Cottage
    England
    England
    United KingdomBritishManaging Director9482280007
    TAYLOR, Richard Charles
    3 King Edwards Court Front Street
    Tynemouth
    NE30 4DZ North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    3 King Edwards Court Front Street
    Tynemouth
    NE30 4DZ North Shields
    Tyne & Wear
    BritishFinancial Controller69207290003
    VERDI, Joseph
    Fairlight Cottage
    Off Holtye Road
    RH19 3QF East Grinstead
    West Sussex
    Amministratore
    Fairlight Cottage
    Off Holtye Road
    RH19 3QF East Grinstead
    West Sussex
    BritishGeneral Manager103102930001
    WINGROVE, Gerald Langdon
    96 Albert Street
    NW1 7NE London
    Amministratore
    96 Albert Street
    NW1 7NE London
    United KingdomBritishFinance Director34815220001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    06 apr 2016
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06658187
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0