LOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED

LOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02774450
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED?

    • Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova LOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LOGICALIS CSF SOLUTIONS LIMITED 08 dic 200608 dic 2006
    CSF SOLUTIONS LIMITED28 ott 199828 ott 1998
    CSF SYSTEMS LIMITED17 dic 199217 dic 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di LOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 feb 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per LOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 06 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2013

    Stato del capitale al 07 gen 2013

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Accounts approved 28/03/2011
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 06 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Ralph Gerald Maingot il 01 dic 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Ian Michael Cook il 01 dic 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Mark Rogers il 01 dic 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 28 feb 2009

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 29 feb 2008

    13 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 28 feb 2007

    12 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    9 pagineMA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed logicalis csf solutions LIMITED\certificate issued on 05/06/07
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di LOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MAINGOT, Ralph Gerald
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Segretario
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    British17515310002
    COOK, Ian Michael
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Amministratore
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    United KingdomBritish93834540001
    ROGERS, Mark
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Amministratore
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    United KingdomBritish109702070001
    GILL, Christopher Thomas
    54 Ellerdale Street
    SE13 7JU Lewisham
    London
    Segretario nominato
    54 Ellerdale Street
    SE13 7JU Lewisham
    London
    British900000950001
    KEEBLE, Christopher Murray
    The Barn
    Main Road
    CO6 3AX Wormingford
    Essex
    Segretario
    The Barn
    Main Road
    CO6 3AX Wormingford
    Essex
    British83991370003
    LAWSON (LONDON) LIMITED
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER
    London
    Segretario nominato
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER
    London
    900000960001
    BEER, Paul Allan
    Mulberry House
    Oxhey Drive South
    HA6 3ET Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Mulberry House
    Oxhey Drive South
    HA6 3ET Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish6436770002
    BESWICK, Jeremy
    11 Nassau Road
    Barnes
    SW13 9QF London
    Amministratore
    11 Nassau Road
    Barnes
    SW13 9QF London
    British66792840001
    BROOKING, Alan St John
    105 Herons Wood
    CM20 1RT Harlow
    Essex
    Amministratore
    105 Herons Wood
    CM20 1RT Harlow
    Essex
    EnglandEnglish78018560001
    COCKRANE-HALL, Diana
    Flat 5 156 Sutherland Avenue
    Maida Vale
    W9 1HP London
    Amministratore
    Flat 5 156 Sutherland Avenue
    Maida Vale
    W9 1HP London
    British111075360001
    COHEN, Michael
    Highfield House
    Theobald Street
    WD7 7LT Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Highfield House
    Theobald Street
    WD7 7LT Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish7193510002
    FOSTER, Nigel Stanton
    26 Warrington Crescent
    W9 1EL London
    Amministratore
    26 Warrington Crescent
    W9 1EL London
    MaltaBritish64001220001
    GREENBERG, David Miles
    Flat A 3 Aberdare Gardens
    NW6 3AJ London
    Amministratore
    Flat A 3 Aberdare Gardens
    NW6 3AJ London
    United KingdomBritish7193520001
    KEEBLE, Christopher Murray
    The Barn
    Main Road
    CO6 3AX Wormingford
    Essex
    Amministratore
    The Barn
    Main Road
    CO6 3AX Wormingford
    Essex
    United KingdomBritish83991370003
    MILLER, Andrew Douglas
    37 St James's Avenue
    Hampton Hill
    TW12 1HH Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    37 St James's Avenue
    Hampton Hill
    TW12 1HH Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritish86026930001
    NORTHALL, Michael John
    27 More Lane
    KT10 8AP Esher
    Surrey
    Amministratore
    27 More Lane
    KT10 8AP Esher
    Surrey
    United KingdomBritish78629090002
    WHITEHOUSE, Philip Ian
    Woodvale
    Drakelow Lane
    DY11 5RY Wolverley
    Worcestershire
    Amministratore
    Woodvale
    Drakelow Lane
    DY11 5RY Wolverley
    Worcestershire
    British98908140001
    WILLIAMS, Ian
    58 Billington Gardens
    Hedge End
    SO30 2RY Southampton
    Amministratore
    58 Billington Gardens
    Hedge End
    SO30 2RY Southampton
    EnglandBritish66204600002

    LOGICALIS COMPUTING SOLUTIONS FINANCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 giu 2002
    Consegnato il 26 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 ott 2001
    Consegnato il 24 ott 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 10 ott 2001
    Consegnato il 16 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    In barclays bank PLC high interest business account number 20418242. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 23 feb 2000
    Consegnato il 02 mar 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement for ibm global financing dated 25TH february 2000
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book and other debts presen and future together with floating charge over all the company's stock in trade and the whole of the charged assets described above if and in so far as the charges created thereon shall for any reason be ineffective as fixed charges. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transazioni
    • 02 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 14 ott 1999
    Consegnato il 16 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement dated 30TH september 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transazioni
    • 16 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 giu 1999
    Consegnato il 09 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 lug 1995
    Consegnato il 13 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 lug 1993
    Consegnato il 17 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Freeland Limited
    Transazioni
    • 17 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0