STUART ALEXANDER LIMITED

STUART ALEXANDER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTUART ALEXANDER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02777604
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STUART ALEXANDER LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova STUART ALEXANDER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STUART ALEXANDER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BISHOPSHALL LIMITED06 gen 199306 gen 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di STUART ALEXANDER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per STUART ALEXANDER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Stato del capitale al 20 dic 2012

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Ian Story come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Martin Keith Tyler come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Stuart Richard Clarke come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Jeremy Peter Small come segretario

    5 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stuart Reid come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graham Coates come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Parsons come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jane Bean come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Graham Story il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Graham Story il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham Marshall Coates il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Charles Reid il 06 ott 2010

    5 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Jane Ann Bean il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di STUART ALEXANDER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    British158292050001
    CLARKE, Stuart Richard
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritish151061560001
    TYLER, Martin Keith
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Great BritainBritish158372390001
    DRUCKMAN, Darryl Martin
    5 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    Segretario
    5 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    British18047610001
    LICKENS, Howard Pierre
    25 Palewell Park
    East Sheen
    SW14 8JQ London
    Segretario
    25 Palewell Park
    East Sheen
    SW14 8JQ London
    British19068000001
    REID, Stuart Charles
    48 Chesilton Road
    SW6 5AB London
    Segretario
    48 Chesilton Road
    SW6 5AB London
    British60698020001
    SHEAD, Leanne Bernadette
    16 Queensmere Road
    SW19 5PB London
    Segretario
    16 Queensmere Road
    SW19 5PB London
    British3793480001
    HARBEN REGISTRARS LIMITED
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    Segretario nominato
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    900001570001
    ALLISON, David Brian
    11 Ruskin Walk
    BR2 8EP Bromley
    Kent
    Amministratore
    11 Ruskin Walk
    BR2 8EP Bromley
    Kent
    EnglandBritish50363660001
    BEAN, Jane Ann
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritish158293780001
    COATES, Graham Marshall
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish139593550001
    DRUCKMAN, Darryl Martin
    5 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    Amministratore
    5 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    EnglandBritish18047610001
    HOOPER, Shaun Ian
    6 Beckworth Close
    Lindfield
    RH16 2EJ Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    6 Beckworth Close
    Lindfield
    RH16 2EJ Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish119362420001
    HUGHES, Norman John
    66 Woodcrest Road
    CR8 4JB Purley
    Surrey
    Amministratore
    66 Woodcrest Road
    CR8 4JB Purley
    Surrey
    EnglandBritish79561290002
    INGE, Nicholas John Kingsford
    8 Orchard Court
    BH31 6JH Verwood
    Dorset
    Amministratore
    8 Orchard Court
    BH31 6JH Verwood
    Dorset
    EnglandBritish78274660002
    LICKENS, Howard Pierre
    25 Palewell Park
    East Sheen
    SW14 8JQ London
    Amministratore
    25 Palewell Park
    East Sheen
    SW14 8JQ London
    EnglandBritish19068000001
    MORSE, Peter Clifford
    16 Percheron Drive
    Knaphill
    GU21 2QY Woking
    Surrey
    Amministratore
    16 Percheron Drive
    Knaphill
    GU21 2QY Woking
    Surrey
    United KingdomBritish116557410001
    NOYCE, Thomas Michael
    90 Billington Gardens
    Hedge End
    SO30 2RT Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    90 Billington Gardens
    Hedge End
    SO30 2RT Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish12259940002
    PARSONS, Andrew Kenneth
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    UkBritish158284950001
    PARSONS, Andrew Mark
    83 Devonshire Road
    Westbury Park
    BS6 7NH Bristol
    Avon
    Amministratore
    83 Devonshire Road
    Westbury Park
    BS6 7NH Bristol
    Avon
    United KingdomBritish121609240001
    POOLE, Andrew
    48 Mindelheim Avenue
    RH19 3UU East Grinstead
    West Sussex
    Amministratore
    48 Mindelheim Avenue
    RH19 3UU East Grinstead
    West Sussex
    British98557740001
    REID, Stuart Charles
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish60698020001
    RITCHIE, Ian Maitland
    28 Goldsmiths Court
    2 Briton Street
    SO14 3ED Southampton
    Amministratore
    28 Goldsmiths Court
    2 Briton Street
    SO14 3ED Southampton
    British82105410001
    SHEAD, Alexander Mark
    16 Queensmere Road
    SW19 5PB London
    Amministratore
    16 Queensmere Road
    SW19 5PB London
    British3793490001
    SHEAD, Anthony David
    Greatbridge House
    Greatbridge
    SO51 0HB Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Greatbridge House
    Greatbridge
    SO51 0HB Romsey
    Hampshire
    British39319300002
    SMITH, Noel Craig
    111 Fordwich Rise
    SG14 2DF Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    111 Fordwich Rise
    SG14 2DF Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish77678660001
    STORY, Ian Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish75238840004
    TYLER, Ronald Douglas
    Redlands
    101 Tycehurst Hill
    IG10 1BZ Loughton
    Essex
    Amministratore
    Redlands
    101 Tycehurst Hill
    IG10 1BZ Loughton
    Essex
    British22052380003
    WEXLER, Brett
    36 Mount Pleasant Road
    IG7 5ER Chigwell
    Essex
    Amministratore
    36 Mount Pleasant Road
    IG7 5ER Chigwell
    Essex
    British100545640001
    HARBEN NOMINEES LIMITED
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    Amministratore delegato nominato
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    900001560001

    STUART ALEXANDER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 set 2004
    Consegnato il 24 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 24 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 ago 1999
    Consegnato il 17 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility loan agreement dated 26TH january 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Axa Insurance PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 gen 1999
    Consegnato il 27 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deposit deed
    Creato il 05 ago 1997
    Consegnato il 07 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-underlease of even date herewith
    Brevi particolari
    £7,000.
    Persone aventi diritto
    • R.M. Campbell
    • N.P. Ready
    • A.J. Burgess
    Transazioni
    • 07 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 10 dic 1996
    Consegnato il 17 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deposit deed
    Creato il 10 dic 1996
    Consegnato il 14 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brevi particolari
    An initial deposit of £8,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anthony Jack Burgess, Nigel Peter Ready and Ruth Margaret Campbell
    Transazioni
    • 14 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0