STUART ALEXANDER LIMITED
Panoramica
| Nome della società | STUART ALEXANDER LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02777604 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STUART ALEXANDER LIMITED?
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova STUART ALEXANDER LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 5 Old Broad Street EC2N 1AD London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STUART ALEXANDER LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BISHOPSHALL LIMITED | 06 gen 1993 | 06 gen 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STUART ALEXANDER LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per STUART ALEXANDER LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Stato del capitale al 20 dic 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Story come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Martin Keith Tyler come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stuart Richard Clarke come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Jeremy Peter Small come segretario | 5 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Reid come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Graham Coates come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Parsons come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jane Bean come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Graham Story il 06 ott 2010 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Graham Story il 06 ott 2010 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham Marshall Coates il 06 ott 2010 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Charles Reid il 06 ott 2010 | 5 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Jane Ann Bean il 06 ott 2010 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di STUART ALEXANDER LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL, Jeremy Peter | Segretario | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 United Kingdom | British | 158292050001 | ||||||
| CLARKE, Stuart Richard | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | British | 151061560001 | |||||
| TYLER, Martin Keith | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 United Kingdom | Great Britain | British | 158372390001 | |||||
| DRUCKMAN, Darryl Martin | Segretario | 5 Coombe Gardens Wimbledon SW20 0QU London | British | 18047610001 | ||||||
| LICKENS, Howard Pierre | Segretario | 25 Palewell Park East Sheen SW14 8JQ London | British | 19068000001 | ||||||
| REID, Stuart Charles | Segretario | 48 Chesilton Road SW6 5AB London | British | 60698020001 | ||||||
| SHEAD, Leanne Bernadette | Segretario | 16 Queensmere Road SW19 5PB London | British | 3793480001 | ||||||
| HARBEN REGISTRARS LIMITED | Segretario nominato | 37 Warren Street W1P 5PD London | 900001570001 | |||||||
| ALLISON, David Brian | Amministratore | 11 Ruskin Walk BR2 8EP Bromley Kent | England | British | 50363660001 | |||||
| BEAN, Jane Ann | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 United Kingdom | England | British | 158293780001 | |||||
| COATES, Graham Marshall | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 139593550001 | |||||
| DRUCKMAN, Darryl Martin | Amministratore | 5 Coombe Gardens Wimbledon SW20 0QU London | England | British | 18047610001 | |||||
| HOOPER, Shaun Ian | Amministratore | 6 Beckworth Close Lindfield RH16 2EJ Haywards Heath West Sussex | England | British | 119362420001 | |||||
| HUGHES, Norman John | Amministratore | 66 Woodcrest Road CR8 4JB Purley Surrey | England | British | 79561290002 | |||||
| INGE, Nicholas John Kingsford | Amministratore | 8 Orchard Court BH31 6JH Verwood Dorset | England | British | 78274660002 | |||||
| LICKENS, Howard Pierre | Amministratore | 25 Palewell Park East Sheen SW14 8JQ London | England | British | 19068000001 | |||||
| MORSE, Peter Clifford | Amministratore | 16 Percheron Drive Knaphill GU21 2QY Woking Surrey | United Kingdom | British | 116557410001 | |||||
| NOYCE, Thomas Michael | Amministratore | 90 Billington Gardens Hedge End SO30 2RT Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 12259940002 | |||||
| PARSONS, Andrew Kenneth | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 United Kingdom | Uk | British | 158284950001 | |||||
| PARSONS, Andrew Mark | Amministratore | 83 Devonshire Road Westbury Park BS6 7NH Bristol Avon | United Kingdom | British | 121609240001 | |||||
| POOLE, Andrew | Amministratore | 48 Mindelheim Avenue RH19 3UU East Grinstead West Sussex | British | 98557740001 | ||||||
| REID, Stuart Charles | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 60698020001 | |||||
| RITCHIE, Ian Maitland | Amministratore | 28 Goldsmiths Court 2 Briton Street SO14 3ED Southampton | British | 82105410001 | ||||||
| SHEAD, Alexander Mark | Amministratore | 16 Queensmere Road SW19 5PB London | British | 3793490001 | ||||||
| SHEAD, Anthony David | Amministratore | Greatbridge House Greatbridge SO51 0HB Romsey Hampshire | British | 39319300002 | ||||||
| SMITH, Noel Craig | Amministratore | 111 Fordwich Rise SG14 2DF Hertford Hertfordshire | United Kingdom | British | 77678660001 | |||||
| STORY, Ian Graham | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 75238840004 | |||||
| TYLER, Ronald Douglas | Amministratore | Redlands 101 Tycehurst Hill IG10 1BZ Loughton Essex | British | 22052380003 | ||||||
| WEXLER, Brett | Amministratore | 36 Mount Pleasant Road IG7 5ER Chigwell Essex | British | 100545640001 | ||||||
| HARBEN NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 37 Warren Street W1P 5PD London | 900001560001 |
STUART ALEXANDER LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 14 set 2004 Consegnato il 24 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 ago 1999 Consegnato il 17 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility loan agreement dated 26TH january 1999 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 25 gen 1999 Consegnato il 27 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security deposit deed | Creato il 05 ago 1997 Consegnato il 07 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-underlease of even date herewith | |
Brevi particolari £7,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 dic 1996 Consegnato il 17 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security deposit deed | Creato il 10 dic 1996 Consegnato il 14 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date | |
Brevi particolari An initial deposit of £8,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0