CONTINENTAL TRUCK LINES LIMITED

CONTINENTAL TRUCK LINES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONTINENTAL TRUCK LINES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02779014
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CONTINENTAL TRUCK LINES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CONTINENTAL TRUCK LINES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Maritime Centre
    Port Of Liverpool
    L21 1LA Liverpool
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONTINENTAL TRUCK LINES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per CONTINENTAL TRUCK LINES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 feb 2013

    Stato del capitale al 08 feb 2013

    • Capitale: GBP 160,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Ian Graeme Lloyd Charnock come amministratore in data 30 nov 2011

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Alan Barr come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Whitworth il 19 gen 2011

    3 pagineCH01

    Nomina di Mr Mark Whitworth come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Thomas Eardley Allison come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Baxter come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Roy Baxter il 25 nov 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CONTINENTAL TRUCK LINES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARRISON GILL, Caroline Ruth
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Segretario
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Other140064590001
    ALLISON, Thomas Eardley
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Amministratore
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    ScotlandBritish1037730004
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish165341530001
    WHITWORTH, Mark
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    Amministratore
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    EnglandBritish120679580002
    BAKER, John Graham
    4 Nenfound Court
    Cringleford
    NR4 7RJ Norwich
    Norfolk
    Segretario
    4 Nenfound Court
    Cringleford
    NR4 7RJ Norwich
    Norfolk
    British32657630001
    BOWLEY, William John
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    British4171240002
    GORAM, Andrew John
    12 Parklands West End
    Old Costessey
    NR8 5AL Norwich
    Norfolk
    Segretario
    12 Parklands West End
    Old Costessey
    NR8 5AL Norwich
    Norfolk
    British41930340001
    PANNONE AND PARTNERS
    123 Deansgate
    M3 2BU Manchester
    Segretario
    123 Deansgate
    M3 2BU Manchester
    41742620001
    SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED
    Scorpio House 102 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    Segretario nominato
    Scorpio House 102 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    900003550001
    ALDRIDGE, George Alexander
    16 Achnacone Drive
    Braiswick
    CO4 5AZ Colchester
    Essex
    Amministratore
    16 Achnacone Drive
    Braiswick
    CO4 5AZ Colchester
    Essex
    EnglandBritish15464150001
    BAKER, John Graham
    4 Nenfound Court
    Cringleford
    NR4 7RJ Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    4 Nenfound Court
    Cringleford
    NR4 7RJ Norwich
    Norfolk
    British32657630001
    BARR, Alan Andrew
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritish121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    Amministratore
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    ScotlandBritish86622660005
    BUSH, Nicholas
    Chimneys
    Back Lane, Washbrook
    IP8 3JA Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Chimneys
    Back Lane, Washbrook
    IP8 3JA Ipswich
    Suffolk
    British96553650001
    COLBY, Peter
    Iveco House
    Ayton Road
    Wymondham
    Norfolk
    Amministratore
    Iveco House
    Ayton Road
    Wymondham
    Norfolk
    British35072470002
    FINDLAY, Alastair Ian
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish30045540003
    GORAM, Andrew John
    12 Parklands West End
    Old Costessey
    NR8 5AL Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    12 Parklands West End
    Old Costessey
    NR8 5AL Norwich
    Norfolk
    British41930340001
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Amministratore
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    British42038120003
    HICKEY, Maurice Andrew
    2 Glenard Hall
    Goatstown Road
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    Amministratore
    2 Glenard Hall
    Goatstown Road
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    Irish47107390001
    O'NEILL, Timothy Joseph
    Coomakesta
    70 The Palms
    IRISH Roebuck Road
    Dublin 14
    Ireland
    Amministratore
    Coomakesta
    70 The Palms
    IRISH Roebuck Road
    Dublin 14
    Ireland
    IrelandIrish92754030001
    SCOTT, Peter Anthony
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    British1674500002
    WHARTON, Kenneth John
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    British9964160002
    SPENCER COMPANY FORMATIONS (DELAWARE) INC
    25 Greystone Manor
    19958 Lewes
    Delaware
    United States Of America
    Amministratore delegato nominato
    25 Greystone Manor
    19958 Lewes
    Delaware
    United States Of America
    900003730001
    SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED
    Scorpio House 102 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    Amministratore delegato nominato
    Scorpio House 102 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    900003550001

    CONTINENTAL TRUCK LINES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security deed of accession
    Creato il 28 feb 2007
    Consegnato il 13 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Secured Creditors
    Transazioni
    • 13 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 mar 2006
    Consegnato il 06 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as security trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 06 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and fixed charge
    Creato il 29 feb 1996
    Consegnato il 08 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facilities agreements (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    First fixed charge overall specified debts and other debts and the collections account and the balance of all monies held therein from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • De Lage Landen Factors Limited
    Transazioni
    • 08 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 apr 1993
    Consegnato il 05 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0