INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED

INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02779282
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sanderson House
    Poplar Way
    S60 5TR Sheffield
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ENTERPRISE MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED25 gen 199325 gen 1993
    CEGONHA LIMITED13 gen 199313 gen 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    2 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Aptean Limited come persona con controllo significativo il 08 apr 2021

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 7 Rushmills Northampton NN4 7YB England a Sanderson House Poplar Way Sheffield South Yorkshire S60 5TR in data 09 apr 2021

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione di Robert Smith come persona con controllo significativo il 23 apr 2019

    1 paginePSC07

    Cessazione della carica di Karen Louise Chalmers come amministratore in data 11 dic 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Kevin James Mcadams come amministratore in data 11 dic 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Nicola Marrison come amministratore in data 11 dic 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sandra Ann Cummings come amministratore in data 11 dic 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2019

    3 pagineAA

    Notifica di Aptean Limited come persona con controllo significativo il 23 apr 2019

    2 paginePSC02

    Iscrizione dell'ipoteca 027792820006, creata il 15 giu 2020

    32 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 027792820005, creata il 15 giu 2020

    32 pagineMR01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Memorandum e Statuto

    43 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Karen Louise Chalmers come amministratore in data 01 gen 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Gibson Somerville come amministratore in data 01 gen 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARRISON, Nicola
    Poplar Way
    S60 5TR Sheffield
    Sanderson House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Poplar Way
    S60 5TR Sheffield
    Sanderson House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector263483420001
    MCADAMS, Kevin James
    Poplar Way
    S60 5TR Sheffield
    Sanderson House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Poplar Way
    S60 5TR Sheffield
    Sanderson House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector277744300001
    STEIN, Hellen Maria
    Poplar Way
    S60 5TR Sheffield
    Sanderson House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Poplar Way
    S60 5TR Sheffield
    Sanderson House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSenior Legal Counsel267152760001
    ANTOINE, Eloise Anne-Marie
    Flat 1
    124 Bailiff Street
    NN1 3EA Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Flat 1
    124 Bailiff Street
    NN1 3EA Northampton
    Northamptonshire
    British110219340002
    ASP, Karl
    Storbergsliden 1
    Sollentuna
    FOREIGN Sweden S 19251
    Segretario
    Storbergsliden 1
    Sollentuna
    FOREIGN Sweden S 19251
    UsaAccountant66275140001
    BEARCROFT, Michael John
    The Coach House
    Farm Lane
    WR11 5SP Atch Lench Eveshan
    Worcestershire
    Segretario
    The Coach House
    Farm Lane
    WR11 5SP Atch Lench Eveshan
    Worcestershire
    BritishCo Director76872660001
    COEN, Timothy Fredericks
    Davis Drive
    GA 30327 Atlanta
    1000
    Georgia
    Usa
    Segretario
    Davis Drive
    GA 30327 Atlanta
    1000
    Georgia
    Usa
    AmericanSenior Vp & General Counsel133948260001
    CUMMINGS, Julian Timothy
    7 Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    Segretario
    7 Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    167172250001
    KANTELIP, Raphael
    Duke Street
    SL4 1SJ Windsor
    57
    Berkshire
    Uk
    Segretario
    Duke Street
    SL4 1SJ Windsor
    57
    Berkshire
    Uk
    FrenchFinancial Controller140548460001
    LONG, Richard
    Apartment 8g
    1601 Samson Street
    Philadelphia Pa 19103
    Usa
    Segretario
    Apartment 8g
    1601 Samson Street
    Philadelphia Pa 19103
    Usa
    British93694720001
    PERSSON, Lars
    Malarvagen 36
    165 72 Hasselby
    Sweden
    Segretario
    Malarvagen 36
    165 72 Hasselby
    Sweden
    Swedish37343100001
    PETERSON, Lars
    Engelbrektsgatan 35
    41137 Goteborg
    Sweden
    Segretario
    Engelbrektsgatan 35
    41137 Goteborg
    Sweden
    SwedishChief Financial Officer41070070001
    TAYLOR, Bryan
    515 Pope Street
    Menlo Park
    California
    94025
    Usa
    Segretario
    515 Pope Street
    Menlo Park
    California
    94025
    Usa
    AmericanDirector87437460001
    TAYLOR, Robert William
    24 Pooley Green Road
    TW20 8AF Egham
    Surrey
    Segretario
    24 Pooley Green Road
    TW20 8AF Egham
    Surrey
    BritishLawyer115640040001
    WEBSTER, Bob
    9 Whitecap Way
    32550 Destin
    Florida
    Usa
    Segretario
    9 Whitecap Way
    32550 Destin
    Florida
    Usa
    AmericanAccountant101149660001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    ASP, Karl
    Storbergsliden 1
    Sollentuna
    FOREIGN Sweden S 19251
    Amministratore
    Storbergsliden 1
    Sollentuna
    FOREIGN Sweden S 19251
    UsaAccountant66275140001
    BEARCROFT, Michael John
    The Coach House
    Farm Lane
    WR11 5SP Atch Lench Eveshan
    Worcestershire
    Amministratore
    The Coach House
    Farm Lane
    WR11 5SP Atch Lench Eveshan
    Worcestershire
    BritishCompany Director76872660001
    BURKETT, Vincent
    Trinity Court
    Wokingham Road
    RG42 1PL Bracknell
    Building C
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Wokingham Road
    RG42 1PL Bracknell
    Building C
    Berkshire
    Texas UsaUsaPrincipal-Private Equity Firm174734880001
    CAMPBELL, Timothy Edward
    3514 Villero Court
    Pleasanton
    Ca 94566
    United States
    Amministratore
    3514 Villero Court
    Pleasanton
    Ca 94566
    United States
    AmericanPresident And Ceo132335700001
    CHALMERS, Karen Louise, Ms.
    Rushmills
    NN4 7YB Northampton
    7
    England
    Amministratore
    Rushmills
    NN4 7YB Northampton
    7
    England
    United KingdomBritishEmea Human Resources Director265852240001
    COEN, Timothy Fredericks
    Davis Drive
    GA 30327 Atlanta
    1000
    Georgia
    Usa
    Amministratore
    Davis Drive
    GA 30327 Atlanta
    1000
    Georgia
    Usa
    AmericanSenior Vp & General Counsel133948260001
    CUMMINGS, Julian Timothy
    7 Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    Amministratore
    7 Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    EnglandBritishVp Finance Emea159136130001
    CUMMINGS, Sandra Ann
    Rushmills
    NN4 7YB Northampton
    7
    England
    Amministratore
    Rushmills
    NN4 7YB Northampton
    7
    England
    United KingdomBritishFinance Director269384760001
    DEXTER, Stephen, Vp
    7 Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    Amministratore
    7 Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    UsaUsaChief Financial Officer159380970001
    DURLOW, Stig George
    Arkiv 7
    Se 411 34 Goteborg
    Sweden
    Amministratore
    Arkiv 7
    Se 411 34 Goteborg
    Sweden
    SwedishManaging Director44648720003
    HICKEY, James
    Trinity Court
    Wokingham Road
    RG42 1PL Bracknell
    Building C
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Wokingham Road
    RG42 1PL Bracknell
    Building C
    Berkshire
    Arizona UsaAmericanPrincipal-Private Equity Firm174734950001
    JOHNSTONE, Linda Frances
    Little Foxes Sheepcote Lane
    Paley Street
    SL6 3JU Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Little Foxes Sheepcote Lane
    Paley Street
    SL6 3JU Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishPresident Ceo Imi76747580001
    KANTELIP, Raphael
    7 Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    Amministratore
    7 Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    United KingdomFrenchFinancial Controller140548460001
    LAVELLE, Matthew
    Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Rushmills
    Northampton
    NN4 7YB Northamptonshire
    7
    United Kingdom
    United StatesAmericanVp, Finance137900080001
    LEIMDORFER, Martin
    Stranovagen 11
    Stockholm
    FOREIGN Sweden 11456
    Amministratore
    Stranovagen 11
    Stockholm
    FOREIGN Sweden 11456
    SwedishPresident58796900002
    MASSEUR, Franciscus Leonardus Lodewijk Arthur
    Divertimentostraat 4
    EC 1312 Almere
    Holland
    Amministratore
    Divertimentostraat 4
    EC 1312 Almere
    Holland
    DutchFinance Director117533800001
    PERSSON, Lars
    Malarvagen 36
    165 72 Hasselby
    Sweden
    Amministratore
    Malarvagen 36
    165 72 Hasselby
    Sweden
    SwedishExecutive Vice President37343100001
    PETERSON, Lars
    Engelbrektsgatan 35
    41137 Goteborg
    Sweden
    Amministratore
    Engelbrektsgatan 35
    41137 Goteborg
    Sweden
    SwedishExecutive Vice President41070070001
    RICHARDS, Martyn
    Pascoli
    Upper Verran Road
    GU15 2JL Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Pascoli
    Upper Verran Road
    GU15 2JL Camberley
    Surrey
    United KingdomBritishComputer Scientist118520700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Poplar Way
    S60 5TR Sheffield
    Sanderson House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    23 apr 2019
    Poplar Way
    S60 5TR Sheffield
    Sanderson House
    South Yorkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03399429
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mr. Robert Smith
    Rushmills
    NN4 7YB Northampton
    7
    England
    06 apr 2016
    Rushmills
    NN4 7YB Northampton
    7
    England
    Nazionalità: American
    Paese di residenza: United States
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    INDUSTRI-MATEMATIK, LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 giu 2020
    Consegnato il 26 giu 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Golub Capital Markets Llc as Collateral Agent
    Transazioni
    • 26 giu 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 giu 2020
    Consegnato il 26 giu 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Golub Capital Markets Llc as Collateral Agent
    Transazioni
    • 26 giu 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A loan and security agreement
    Creato il 27 gen 2003
    Consegnato il 13 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The collateral - accounts,books,equipment,general intangibles,inventory,investments property, negotiable collateral.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Foothill Capital Corporation
    Transazioni
    • 13 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2003
    Consegnato il 13 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Foothill Capital Corporation
    Transazioni
    • 13 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 14 apr 1998
    Consegnato il 18 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date herewith
    Brevi particolari
    The sums deposited in the deposit account pursuant to the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Campmoss Property Company Limited
    Transazioni
    • 18 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 28 ago 1995
    Consegnato il 02 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 28TH july 1995
    Brevi particolari
    The sum of £30,000 together with V.A.T. on such sum deposited with lloyds bank PLC in an account designated highloch properties limited and industri-matematik limited rent deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Highloch Properties Limited
    Transazioni
    • 02 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0