HILLCREST CARE HOMES LIMITED

HILLCREST CARE HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHILLCREST CARE HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02780067
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HILLCREST CARE HOMES LIMITED?

    • Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova HILLCREST CARE HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Evelyn Partners Llp
    45 Gresham Street
    EC2V 7BG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HILLCREST CARE HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STANSOAK LIMITED15 gen 199315 gen 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di HILLCREST CARE HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per HILLCREST CARE HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    27 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 dic 2023

    26 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 dic 2022

    26 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY a C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG in data 06 lug 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 dic 2021

    25 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Merchants Drive Parkhouse Carlisle CA3 0JW England a C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY in data 30 dic 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 17 dic 2020

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 11th Floor Two Snowhill Birmingham B4 6WR a 2 Merchants Drive Parkhouse Carlisle CA3 0JW in data 05 nov 2018

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 027800670009 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 027800670010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 027800670008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 027800670007 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    22 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew Cardwell Glowasky il 03 lug 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio modificato redatto al 31 mar 2016

    22 pagineAAMD

    Chi sono gli amministratori di HILLCREST CARE HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GLOWASKY, Matthew Cardwell
    45 Gresham Street
    EC2V 7BG London
    C/O Evelyn Partners Llp
    Amministratore
    45 Gresham Street
    EC2V 7BG London
    C/O Evelyn Partners Llp
    United KingdomAmericanInvestment Professional193738080002
    SMITH, Philip Antony
    45 Gresham Street
    EC2V 7BG London
    C/O Evelyn Partners Llp
    Amministratore
    45 Gresham Street
    EC2V 7BG London
    C/O Evelyn Partners Llp
    United KingdomBritishCompany Director168800430001
    BROWN, Geoffrey Francis
    Two Snowhill
    B4 6WR Birmingham
    11th Floor
    England
    Segretario
    Two Snowhill
    B4 6WR Birmingham
    11th Floor
    England
    179582060001
    GILL, Jaswant Singh
    39 Montague Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    39 Montague Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    BritishNursing Home Proprietor33889910002
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MADDISON, Stephen Alderson
    28 Bourne Avenue
    DL1 1LN Darlington
    Co Durham
    Segretario
    28 Bourne Avenue
    DL1 1LN Darlington
    Co Durham
    BritishAccountant68971040002
    WHITAKER, Anne Michelle
    3 Tennyson Avenue
    Sutton Coldfield
    West Midlands
    England
    Segretario nominato
    3 Tennyson Avenue
    Sutton Coldfield
    West Midlands
    England
    British900005230001
    FINLYSON, Duncan James
    Marlborough House
    Holly Walk
    CV32 4LS Leamington Spa
    Amministratore
    Marlborough House
    Holly Walk
    CV32 4LS Leamington Spa
    BritishExcutive44713280001
    GILL, Jaswant Singh
    39 Montague Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    39 Montague Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishNursing Home Proprietor33889910002
    GILL, Sewa Singh
    39 Montague Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    39 Montague Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishNursing Home Proprietor33889920002
    HARRISON, David Michael
    Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle-Upon-Tyne
    62
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle-Upon-Tyne
    62
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishAccountant139713380001
    HARRISON, Simon Joseph
    Middle Garth Drive
    South Cave
    HU15 2AY Brough
    7
    North Humberside
    England
    Amministratore
    Middle Garth Drive
    South Cave
    HU15 2AY Brough
    7
    North Humberside
    England
    EnglandBritishProfessional Interim Director183587330001
    HOUGHTON, Jennifer Pamela
    Primrose Lodge
    Dissington Lane
    NE15 0AB Ponteland
    Northumberland
    Amministratore
    Primrose Lodge
    Dissington Lane
    NE15 0AB Ponteland
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector48281920002
    MUSGRAVE, Paul
    August Court Yard
    NE8 2DL Gateshead
    11
    Tyne & Wear
    England
    Amministratore
    August Court Yard
    NE8 2DL Gateshead
    11
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritishDirector138904530001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HILLCREST CARE HOMES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dolphin Property Company Limited
    Snow Hill Queensway
    B4 6WR Birmingham
    2
    England
    06 apr 2016
    Snow Hill Queensway
    B4 6WR Birmingham
    2
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione02904093
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HILLCREST CARE HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2014
    Consegnato il 05 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 ott 2013
    Consegnato il 25 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 ott 2013
    Consegnato il 25 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land at wear street jarrow t/no TY311811. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 ott 2013
    Consegnato il 25 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 ago 2006
    Consegnato il 09 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 2006
    Consegnato il 09 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at wear street jarrow t/no ty 311811. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge deed
    Creato il 17 mar 2004
    Consegnato il 22 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the property being hillcrest care home wear stret jarrow tyne and wear and all fixtures and fittings by way of fixed charge the equipment and all other fixtures fittings by way of floating charge all other moveable plant machinery undertaking and all other property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Skipton Building Society
    Transazioni
    • 22 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge made between the company,svenska palmer (construction) LTD and aib group (UK) PLC
    Creato il 14 mag 2001
    Consegnato il 17 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment the building agreement dated 9/2/2001 and all the benefit thereof relating to premises at wear st,jarrow,tyne and wear; t/no ty 311811.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 feb 2001
    Consegnato il 27 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at wear street jarrow tyne & wear t/n TY311811. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 feb 2001
    Consegnato il 27 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HILLCREST CARE HOMES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 dic 2020Inizio della liquidazione
    03 giu 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kevin Ley
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Praticante
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Colin Hardman
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Praticante
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0