PILLAR (BECKTON) LIMITED

PILLAR (BECKTON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPILLAR (BECKTON) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02783376
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PILLAR (BECKTON) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova PILLAR (BECKTON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PILLAR (BECKTON) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARINV (WEST END) LIMITED08 set 199308 set 1993
    GOULDITAR NO. 267 LIMITED25 gen 199325 gen 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di PILLAR (BECKTON) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per PILLAR (BECKTON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Benjamin Toby Grose come amministratore in data 02 dic 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019

    14 pagineAA

    legacy

    206 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Bruce Michael James come amministratore in data 10 apr 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Philip John Martin come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip John Martin come segretario in data 31 ott 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di British Land Company Secretarial Limited come segretario in data 31 ott 2016

    2 pagineAP04

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2016

    13 pagineAA

    legacy

    210 paginePARENT_ACC

    legacy

    4 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Chi sono gli amministratori di PILLAR (BECKTON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    MARTIN, Philip John
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    Segretario
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    British35118050001
    MEENAGHAN, Evelyn Maria
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    Segretario nominato
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    British900001370001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Amministratore
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MAXTED, Robert David
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    Amministratore
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    British37177990001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Amministratore
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    MOULD, Harold Raymond
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    Amministratore
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    EnglandBritish35576350006
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    SEATON, Stuart Neil
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Amministratore delegato nominato
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    United KingdomBritish900001360001
    SHEEHAN, Nicholas John Philip
    Herons Farm
    Kirdford
    RH14 0ND Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Herons Farm
    Kirdford
    RH14 0ND Billingshurst
    West Sussex
    British39476870002
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PILLAR (BECKTON) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Pillar Property Group Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    25 gen 2017
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione02570618
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PILLAR (BECKTON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment in security
    Creato il 21 dic 2003
    Consegnato il 31 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assignors rights interests and benefits in and to the loan agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 set 2003
    Consegnato il 03 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a gallions reach shopping park beckton t/n EGL423215 and EGL423311. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 giu 2002
    Consegnato il 20 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from an obligor or by some other person of each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including the freehold property known as gallions reach shopping park,beckton; EGL423215 and EGL423311. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais,London Branch,as Agent and Trustee for Each of the Finance Parties
    Transazioni
    • 20 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 apr 2001
    Consegnato il 04 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clauses 3.5(b) and (c) of a variation agreement dated 2 february 2001 (as defined) being deferred consideration of £9,700,000.00 due on 21 june 2001 and £9,700,000.00 due on 21 december 2001
    Brevi particolari
    F/Hold land/blds known as part of gallons reach,beckton with all buildings,fixtures,fixed plant and machinery thereon.
    Persone aventi diritto
    • Lattice Property Holdings Limited
    Transazioni
    • 04 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 dic 1996
    Consegnato il 06 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the "finance document"
    Brevi particolari
    Aquila house soho square london. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Sumitomo Bank Limited
    Transazioni
    • 06 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 set 1993
    Consegnato il 21 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the terms of each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Aquila house, soho square, london t/nos. LN17685, 392206, LN23994, LN83684 and 41763. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale, London Branch
    Transazioni
    • 21 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0