SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED

SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02783861
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED?

    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    50 Greenhead Road, Gledholt
    Huddersfield
    HD1 4EZ W Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMMERCIAL MERIT LIMITED26 gen 199326 gen 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 28 feb 2022

    6 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2022 al 28 feb 2022

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2021

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2019

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Katherine Rachel Manby il 01 giu 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Katherine Rachel Manby il 01 giu 2019

    1 pagineCH03

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2018

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREEN, Katherine Rachel
    50 Greenhead Road, Gledholt
    Huddersfield
    HD1 4EZ W Yorkshire
    Segretario
    50 Greenhead Road, Gledholt
    Huddersfield
    HD1 4EZ W Yorkshire
    British80165930002
    GREEN, Katherine Rachel
    50 Greenhead Road
    Gledholt
    HD1 4EZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    50 Greenhead Road
    Gledholt
    HD1 4EZ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishSolicitor80165930002
    MANBY, Janice Lorraine
    50 Greenhead Road
    Gled Holt
    HD1 4EZ Huddersfield
    Amministratore
    50 Greenhead Road
    Gled Holt
    HD1 4EZ Huddersfield
    EnglandBritishProperty Owner59685070001
    MANBY, Joanna Louise
    50 Greenhead Road
    HD1 4EZ Huddersfield
    W Yorkshire
    Amministratore
    50 Greenhead Road
    HD1 4EZ Huddersfield
    W Yorkshire
    United KingdomBritishVeterinary Surgeon122470290001
    BREARLEY, Beverley
    171 Moor Lane
    Netherton
    HD4 7JN Huddersfield
    Segretario
    171 Moor Lane
    Netherton
    HD4 7JN Huddersfield
    British35318110002
    MANBY, Janice Lorraine
    50 Greenhead Road
    Gled Holt
    HD1 4EZ Huddersfield
    Segretario
    50 Greenhead Road
    Gled Holt
    HD1 4EZ Huddersfield
    British59685070001
    MANBY, Janice Lorraine
    50 Greenhead Road
    Gled Holt
    HD1 4EZ Huddersfield
    Segretario
    50 Greenhead Road
    Gled Holt
    HD1 4EZ Huddersfield
    British59685070001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BREARLEY, Beverley
    171 Moor Lane
    Netherton
    HD4 7JN Huddersfield
    Amministratore
    171 Moor Lane
    Netherton
    HD4 7JN Huddersfield
    BritishCompany Director35318110002
    DWORSKY, Marianne
    Sun Flower Cottage
    Westgate Almondbury
    HD5 8XF Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sun Flower Cottage
    Westgate Almondbury
    HD5 8XF Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishRecruitment Consultant102918760001
    MANBY, Janice Lorraine
    50 Greenhead Road
    Gled Holt
    HD1 4EZ Huddersfield
    Amministratore
    50 Greenhead Road
    Gled Holt
    HD1 4EZ Huddersfield
    EnglandBritishDirector59685070001
    MYATT, Glenn
    50 Greenhead Road
    Gledholt
    HD1 4EZ Huddersfield
    Amministratore
    50 Greenhead Road
    Gledholt
    HD1 4EZ Huddersfield
    BritishCompany Director76139840001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Janice Lorraine Manby
    50 Greenhead Road, Gledholt
    Huddersfield
    HD1 4EZ W Yorkshire
    26 gen 2017
    50 Greenhead Road, Gledholt
    Huddersfield
    HD1 4EZ W Yorkshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 2000
    Consegnato il 30 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £25,000.00 and interest on gemini magazines limited obligations up to the sum of £25,000.00 from the earlier of the time yorkshire bank PLC demand payment from gemini magazines limited of their obligations and notify the demand to sellars property services (1993) limited in accordance with paragraph 20 of the mortgage deed and in accordance with paragraph 4.2 of the mortgage deed,as defined
    Brevi particolari
    12 thornhill rd,longwood huddersfield.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 2000
    Consegnato il 30 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £20,000.00 and interest on gemini magazines limited obligations up to the sum of £20,000.00 from the earlier of the time yorkshire bank PLC demand payment from gemini magazines limited of their obligations and notify the demand to sellars property services (1993) limited in accordance with paragraph 20 of the mortgage deed and in accordance with paragraph 4.2 of the mortgage deed,as defined
    Brevi particolari
    20 chapel terrace crosland moor huddersfield.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 2000
    Consegnato il 30 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £25,000.00 and interest on gemini magazines limited obligations up to the sum of £25,000.00 from the earlier of the time yorkshire bank PLC demand payment from gemini magazines limited of their obligations and notify the demand to sellars property services (1993) limited in accordance with paragraph 20 of the mortgage deed and in accordance with paragraph 4.2 of the mortgage deed,as defined
    Brevi particolari
    327 leymoor rd,golcar huddersfield.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2003Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 08 gen 2004Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
    • 14 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
      • Numero di pratica 1
    Fixed and floating charge
    Creato il 14 dic 1998
    Consegnato il 16 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and other liabilities and obligations due or to become due from the company (t/a the gemini group) to the chargee on any account whatsoever whether under the agreement (as defined) or otherwise
    Brevi particolari
    Any present or future debt (purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement) the ownership of which fail to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason together with the related rights (as defined in the agreement) pertaining to such debt (the "factored debts"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Maddox Factoring (UK) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 10 dic 1996
    Consegnato il 27 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 117 somerset road almondbury huddersfield together with all fixtures and fittings plant and machinery thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 27 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 10 dic 1996
    Consegnato il 24 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    12 thornhill road longwood huddersfield including all fixtures fittings (other than trade fixtures and fittings) plant machinery. By way of floating charge all moveable fixtures fittings plant machinery equipment materials and articles. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 dic 1995
    Consegnato il 10 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    327 leymoor road golcar huddersfield west yorkshire with all fixtures fittings plant & machinery and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ago 1995
    Consegnato il 13 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at 568 leeds road, huddersfield. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    SELLARS PROPERTY SERVICES (1993) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 nov 2000Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Parkinson
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Praticante
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Praticante
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0