NP CO REALISATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NP CO REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02788727 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NP CO REALISATIONS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NP CO REALISATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o AMY CHISMON 7 More London Riverside SE1 2RT London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NP CO REALISATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| NUPAC LIMITED | 10 giu 1993 | 10 giu 1993 |
| SCOREPAC LIMITED | 27 apr 1993 | 27 apr 1993 |
| TIMESPARE LIMITED | 10 feb 1993 | 10 feb 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NP CO REALISATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per NP CO REALISATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Patrick Dancaster come amministratore in data 11 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 103 Baker Street London W1U 6LN a C/O Amy Chismon 7 More London Riverside London SE1 2RT in data 15 nov 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Angad Paul come amministratore in data 08 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed nupac LIMITED\certificate issued on 29/12/15 | 4 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Smith come amministratore in data 03 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Claire Smith come amministratore in data 17 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Georgina Mason come amministratore in data 16 feb 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Patrick Dancaster come amministratore in data 01 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Hyland come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Miss Georgina Mason come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Stilwell come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Stilwell come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NP CO REALISATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Segretario | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | British | 108203800001 | ||||||
| SMITH, John Godfrey | Segretario | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | British | 56051330001 | ||||||
| STEELE, Colin Grant | Segretario | Hindrum Cokes Lane HP8 4UD Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 10618480001 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Segretario | 103 Baker Street London W1U 6LN | 150812690001 | |||||||
| RUTLAND SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 900005290001 | |||||||
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Amministratore | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | England | British | 108203800001 | |||||
| BRITTON, Charles Jonathan | Amministratore | 19 High Street Avening GL8 8NF Tetbury Gloucestershire | British | 34146250001 | ||||||
| DANCASTER, David Patrick | Amministratore | 103 Baker Street W1U 6LN London Caparo House | England | British | 55380530001 | |||||
| DANCASTER, David Patrick | Amministratore | Baker Street W1U 6LN London Caparo House 103 | England | British | 55380530001 | |||||
| DICKINSON, John Alan | Amministratore | Moor Old Lodge 6 Moor Hall Drive Four Oaks B75 6LP Sutton Coldfield West Midlands | British | 28823880001 | ||||||
| HYLAND, Matthew William Edward | Amministratore | Popes Lane B69 4PJ Oldbury Caparo House West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 152453950001 | |||||
| LEEK, James Anthony | Amministratore | 8 Atherton Drive Wimbledon SW19 5LB London | British | 11293430001 | ||||||
| MASON, Georgina | Amministratore | 103 Baker Street London W1U 6LN | England | British | 173302440001 | |||||
| PAUL, Angad, The Honorable | Amministratore | Ambika House 9a Portland Place W1B 1PR London The Penthouse Flat | United Kingdom | United Kingdom | 130813310001 | |||||
| ROBERTSON, Christopher Douglas | Amministratore | 18 Tudor Way CH3 5XQ Deva Park Chemor | British | 44883240001 | ||||||
| SMITH, Claire | Amministratore | 103 Baker Street London W1U 6LN | England | British | 195772990001 | |||||
| SMITH, John Godfrey | Amministratore | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 56051330001 | |||||
| STEELE, Colin Grant | Amministratore | Hindrum Cokes Lane HP8 4UD Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 10618480001 | |||||
| STILWELL, Michael James | Amministratore | 103 Baker Street London W1U 6LN | United Kingdom | British | 142098630001 | |||||
| WALKER, Craig Anthony | Amministratore | 30 Corncrake Way OX26 6UE Bicester Oxfordshire | New Zealander | 75201130003 | ||||||
| WOOD, John Franklin | Amministratore | 27 Oak Hill Drive Edgbaston B15 3UG Birmingham West Midlands | England | British | 1397720001 | |||||
| RUTLAND DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 900005280001 |
NP CO REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 30 lug 2010 Consegnato il 06 ago 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts | Creato il 31 gen 2002 Consegnato il 14 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari (I) fixed equitable charge any debt(as defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement including its related rights (purchased debts) both present and future which fail to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason and (ii) fixed equitable charge all amounts of indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever incuding the related rights, other than any purchased debt (other debts) and (iii) floating charge such monies the company may receive in respect of the other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0