B.C. TECHNOLOGY LIMITED
Panoramica
Nome della società | B.C. TECHNOLOGY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02790358 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di B.C. TECHNOLOGY LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di apparecchi radiofonici, televisivi ed elettrodomestici (esclusi nastri magnetici, dischi, CD e videocassette e le apparecchiature per la loro riproduzione) (46439) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova B.C. TECHNOLOGY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O MAZARS LLP 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di B.C. TECHNOLOGY LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GRANTLOCAL COMPANY LIMITED | 16 feb 1993 | 16 feb 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di B.C. TECHNOLOGY LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per B.C. TECHNOLOGY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 16 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Headlands House 1 Kings Court Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6WJ, England a 45 Church Street Birmingham B3 2RT in data 15 mag 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Premium Warehousing, Sywell Aerodrome Wellingborough Road Northampton NN6 0BN | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in parte | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Johanna Elisabeth Schlimmer come amministratore in data 15 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Johanna Elisabeth Schlimmer il 06 giu 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Schlimmer il 06 giu 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Bc Tec House Wallis Close, Park Farm Industrial Estate, Wellingborough, Northants Nn8 6 Ag a 45 Church Street Birmingham B3 2RT in data 09 dic 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Meadows Nominees Limited come segretario in data 30 lug 2015 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Justyna Pittam come segretario in data 30 lug 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Seymour come amministratore in data 03 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Schlimmer il 06 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di B.C. TECHNOLOGY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEADOWS NOMINEES LIMITED | Segretario | Kettering Parkway NN15 6WJ Kettering Headlands House 1 Kings Court Northamptonshire England |
| 129888850001 | ||||||||||
SCHLIMMER, Robert | Amministratore | 6741zw Lunteren Mielweg 61 The Netherlands Netherlands | Netherlands | Dutch | Company Director | 34155790010 | ||||||||
KELLETT, Anthony Featherstone | Segretario | 2 Lammas Close NN14 1JJ Orlingbury Northamptonshire | British | Company Director | 34155780001 | |||||||||
PITTAM, Justyna | Segretario | Bc Tec House Wallis Close Park Farm Industrial Estate Wellingborough Northants Nn8 6 Ag | 179303400001 | |||||||||||
SCHLIMMER, Johanna Elisabeth | Segretario | The Thatched House Stanton Road Harcourt Hill OX2 9AS Oxford | Dutch | 35344060002 | ||||||||||
SOMERFIELD, Annette Mandy | Segretario | 36 Shelley Drive NN8 5WA Higham Ferrers Northants | British | 106279780002 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
SCHLIMMER, Johanna Elisabeth | Amministratore | 6741zw Lunteren Mielweg 61 The Netherlands Netherlands | The Netherlands | Dutch | Director | 35344060008 | ||||||||
SEYMOUR, Stephen | Amministratore | Bc Tec House Wallis Close Park Farm Industrial Estate Wellingborough Northants Nn8 6 Ag | England | English | Joint Md | 160738660001 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di B.C. TECHNOLOGY LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Robert Schlimmer | 06 apr 2016 | 6741zw Lunteren Mielweg 61 The Netherlands Netherlands | No |
Nazionalità: Dutch Paese di residenza: Netherlands | |||
Natura del controllo
|
B.C. TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 06 ago 2004 Consegnato il 07 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 mag 2002 Consegnato il 10 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
All assets debenture | Creato il 14 lug 2000 Consegnato il 18 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage deed | Creato il 26 mar 1997 Consegnato il 28 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H site T9 and land adjoining wallis close park farm industrial estate wellingbourough northants with all buildings & fixtures and trade fixtures fixed plant and machinery and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 13 lug 1993 Consegnato il 16 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 20 apr 1993 Consegnato il 22 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
B.C. TECHNOLOGY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0