CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED

CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02795595
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HAJCO 116 LIMITED03 mar 199303 mar 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 dic 2020

    21 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 dic 2019

    21 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 dic 2018

    21 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 dic 2017

    20 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 dic 2016

    28 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:secretary of state certificate of release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:court order replacement/removal of liquidator
    10 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 dic 2015

    12 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP a Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP in data 22 gen 2015

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Osprey House Ore Close Lymedale Business Park Newcastle Under Lyme Staffordshire ST5 9QD a Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP in data 12 gen 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    8 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 19 dic 2014

    LRESEX

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Timothy Whiting come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Dobson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Nicholas Kassler come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Steven Lloyd come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 nov 2013

    Stato del capitale al 22 nov 2013

    • Capitale: GBP 48,683,990.5
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    15 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 027955950009

    10 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LLOYD, Steven
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Segretario
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    British127681060001
    KASSLER, David Nicholas
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    EnglandBritish,AmericanDirector139908820001
    LLOYD, Steven
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector139477080001
    MORRIS, John Edward
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector92903390003
    BENNETT, Craig
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    Segretario
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    BritishCompany Director34704080002
    HAJCO SECRETARIES LIMITED
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Segretario nominato
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    900006890001
    BENNETT, Craig
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    Amministratore
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director34704080002
    CAUDWELL, Brian, Mr.
    Brooklands
    Sarisbury Green
    SO31 7EE Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Brooklands
    Sarisbury Green
    SO31 7EE Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director15920410004
    CAUDWELL, John David
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    Amministratore
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    EnglandBritishManaging Director21185880002
    DOBSON, Philip David
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    Amministratore
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector95437530004
    LLOYD, Steven
    5 Harrow Place
    ST15 8ST Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Harrow Place
    ST15 8ST Stone
    Staffordshire
    BritishDirector127681060001
    MORRIS, Barry
    15 Applebrook
    TF11 9PZ Shifnal
    Salop
    Amministratore
    15 Applebrook
    TF11 9PZ Shifnal
    Salop
    BritishDirector100825540001
    O'KEEFFE, Gerard
    4 Trevone Close
    WA16 9EJ Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    4 Trevone Close
    WA16 9EJ Knutsford
    Cheshire
    IrishAccountant80561290001
    RYAN, Mark Stephen
    Cotes Hall Cotes Heath
    ST21 6RT Eccleshall
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Cotes Hall Cotes Heath
    ST21 6RT Eccleshall
    Staffordshire
    England
    BritishCompany Director61915760005
    WHITING, Timothy James
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    Amministratore
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector44028500003
    WILLIAMS, Stephen David
    2 Balcombe Close
    ST5 2DX Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    2 Balcombe Close
    ST5 2DX Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishAccountant91659230001
    HAJCO DIRECTORS LIMITED
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore delegato nominato
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    900006880001

    CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2013
    Consegnato il 24 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    An omnibus set-off agreement
    Creato il 22 dic 2011
    Consegnato il 23 dic 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Creato il 12 feb 2010
    Consegnato il 12 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Consent letter
    Creato il 08 dic 2009
    Consegnato il 18 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The short particulars of all the property mortgaged or charged are as set out in the debenture, in the consent letter the company charges, all investments, including any dividend, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transazioni
    • 18 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Omnibus letter of set-off (oslo)
    Creato il 24 set 2009
    Consegnato il 01 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 11 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charger to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V, London Branch as Security Trustee for the Secured Creditors (The Securitytrustee)
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over credit balances
    Creato il 20 mar 2006
    Consegnato il 05 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from lsg insurance (isle of man) limited to the chargee on any account whatsoever not exceeding one million pounds under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A fixed charge over all sums of moneys now or at any time hereafter standing to the credit of the account of the company with the bank referred to in the schedule together with all interest from time to time accruing thereon as continuing security for the secured liabilities barclays private clients international limited re caudwell subsidiary holdings limited present account number (where relevant account bank) 10415391 barclays bank PLC douglas isle of man.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Private Clients International Limited
    Transazioni
    • 05 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 dic 1994
    Consegnato il 15 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 set 1994
    Consegnato il 23 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 23 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CAUDWELL SUBSIDIARY HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 feb 2022Data prevista di scioglimento
    19 dic 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David James Kelly
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Jonathan Hunt
    19 Cornwall Court
    BS1 5QD Birmingham
    Praticante
    19 Cornwall Court
    BS1 5QD Birmingham
    Robert John Moran
    7 More London
    Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London
    Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0