SINGLEPOINT (4U) LIMITED

SINGLEPOINT (4U) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSINGLEPOINT (4U) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02795597
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    4U LIMITED03 ott 199403 ott 1994
    CAUDWELL AIRTIME SERVICES LIMITED28 mag 199328 mag 1993
    HAJCO 117 LIMITED03 mar 199303 mar 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 mar 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mrs Janine Butler come amministratore in data 23 feb 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Nigel Evans come amministratore in data 23 feb 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019

    10 pagineAA

    legacy

    256 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Nomina di Mr Andrew Michael Yorston come amministratore in data 02 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Diane Josephine Mcintyre come amministratore in data 16 mar 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    75473330004
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish277534960001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish257275320001
    BENNETT, Craig
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    British34704080001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    HAJCO SECRETARIES LIMITED
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Segretario nominato
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    900006890001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BARTON, John Michael
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    British34831450001
    BENNETT, Craig
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    British34704080001
    BIRNEY, James Gary
    Three Acre Wood
    Bridgemere Lane
    CW5 7PL Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    Three Acre Wood
    Bridgemere Lane
    CW5 7PL Nantwich
    Cheshire
    British86869670001
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    BROWN, Peter
    Hawthorne Cottage
    19 Station Road Barlaston
    ST12 9DH Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Hawthorne Cottage
    19 Station Road Barlaston
    ST12 9DH Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    British58317370001
    CAUDWELL, Brian
    Fradswell Hall Fradswell
    ST18 0EX Stafford
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Fradswell Hall Fradswell
    ST18 0EX Stafford
    Staffordshire
    England
    British15920410002
    CAUDWELL, John David
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    Amministratore
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    EnglandBritish21185880002
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    DARBY, Gavin John
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish99277850001
    DAVIES, Andrew Mark
    19 Burnside
    WA15 0SG Halebarns
    Cheshire
    Amministratore
    19 Burnside
    WA15 0SG Halebarns
    Cheshire
    British86869710001
    DOBSON, Philip
    The Holtridge
    Norbury Nr Cholmondeley
    SY13 4JA Whitchurch
    Shropshire
    Amministratore
    The Holtridge
    Norbury Nr Cholmondeley
    SY13 4JA Whitchurch
    Shropshire
    British95437530001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    HUMPHREYS, Christopher Andrew
    Bowden House
    Bowden Lane, Marple
    SK6 6ND Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Bowden House
    Bowden Lane, Marple
    SK6 6ND Stockport
    Cheshire
    British77737010001
    JACKSON, Stephen Paul
    11 Pollard Drive
    Stapeley
    CW5 7EQ Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    11 Pollard Drive
    Stapeley
    CW5 7EQ Nantwich
    Cheshire
    British74412960001
    KEAYS, Helen Margaret
    The Old Vicarage
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish81221470001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish173703620001
    MORROW, William Thomas
    5415 Blackhawk Drive
    Danville
    California 94506
    Usa
    Amministratore
    5415 Blackhawk Drive
    Danville
    California 94506
    Usa
    American95677940001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    PHILLIPS, Thomas Adam
    The Old Stable House Sun Farm
    Fradswell
    ST18 0EY Stafford
    Amministratore
    The Old Stable House Sun Farm
    Fradswell
    ST18 0EY Stafford
    United KingdomBritish55928770001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    STEWART, Gregory Kenneth
    1 The Grove
    CW6 0GB Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    1 The Grove
    CW6 0GB Tarporley
    Cheshire
    British80561450001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalian103542080002

    Chi sono le persone con controllo significativo di SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2227940
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SINGLEPOINT (4U) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 03 feb 2003
    Consegnato il 14 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 26 mar 2002
    Consegnato il 03 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All claims choses in action intellectual property and goodwill of the company present and future in so far as the same are comprised in the subscriber base arising under the service provider agreement and any other rights benefits or interests now and in the future comprised in the subscriber base. All book debts now and in the future owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bt Cellnet
    Transazioni
    • 03 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 03 gen 2002
    Consegnato il 16 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge its undertaking and assets both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Vodafone Limited
    Transazioni
    • 16 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 dic 1997
    Consegnato il 29 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 dic 1994
    Consegnato il 15 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 set 1994
    Consegnato il 23 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 23 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 22 lug 1993
    Consegnato il 24 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreements or either of them or any subsequent agreement (as defined)
    Brevi particolari
    The interest of the company in its customers from time to time concerning or inrelation to telecommunications services provided in whole or part on the vodafone network and all goodwill associated therewith (the subscriber base), first fixed charge all goodwill and uncalled capital intellectual property rights all book debts and other debts and first floating charge charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Vodafone Limited
    Transazioni
    • 24 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0