TNG LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTNG LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02795833
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TNG LIMITED?

    • Altra istruzione n.c.a. (85590) / Istruzione

    Dove si trova TNG LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    19-20 The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TNG LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE TRAINING NETWORK GROUP LIMITED04 mar 199304 mar 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di TNG LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2016
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TNG LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Simon Collins come segretario in data 12 ago 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Antony Keegan come segretario in data 12 ago 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Phillip Neil Ledgard come amministratore in data 31 mag 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christopher Mark Pullen come amministratore in data 18 apr 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 04 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 mar 2016

    Stato del capitale al 30 mar 2016

    • Capitale: GBP 1,724
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 apr 2015

    Stato del capitale al 03 apr 2015

    • Capitale: GBP 1,724
    SH01

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    10 pagineAA

    Cessazione della carica di Colin William Martin come amministratore in data 12 nov 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Brooks come amministratore in data 12 nov 2014

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2Nd Floor Churchwood House 116 Cockfosters Road Cockfosters Hertfordshire EN4 0DR* in data 07 lug 2014

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Peter Ashcroft come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Stuart Vere come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Susan Brain England come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Janette Faherty come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Antony Keegan come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stuart Walkley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew John Hogarth come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TNG LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLINS, Paul Simon
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    Segretario
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    212127650001
    HOGARTH, Andrew John
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    England
    Amministratore
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    England
    United KingdomBritishManaging Director42076600007
    PULLEN, Christopher Mark
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    Amministratore
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    United KingdomBritishChief Financial Officer121886170002
    ASHCROFT, Peter David
    37 Teal Court
    Herons Reach
    FY3 8FT Blackpool
    Lancashire
    Segretario
    37 Teal Court
    Herons Reach
    FY3 8FT Blackpool
    Lancashire
    British81743930002
    FAHERTY, Janette Morag
    8 Brackendale
    Winchmore Hill
    N21 3DG London
    Segretario
    8 Brackendale
    Winchmore Hill
    N21 3DG London
    BritishChief Executive7278060002
    KEEGAN, Mark Antony
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    England
    Segretario
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    England
    189143910001
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    BRAIN ENGLAND, Susan Maria
    Beech House Vicarage Gardens
    Birkenshaw
    BD11 2EF Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Beech House Vicarage Gardens
    Birkenshaw
    BD11 2EF Bradford
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Director126626970001
    BROOKS, Peter James
    Overton Drive
    Wanstead
    E11 2NJ London
    44
    Amministratore
    Overton Drive
    Wanstead
    E11 2NJ London
    44
    EnglandBritishManaging Director132541300001
    BROWN, Christine Marjorie
    19 Griffiths Street
    NN10 0RL Rushden
    Northamptonshire
    Amministratore
    19 Griffiths Street
    NN10 0RL Rushden
    Northamptonshire
    BritishArea Manager62056040001
    DONNELLY, Michael, Major
    4b Ambleside Avenue
    SW16 6AD Streatham
    London
    Amministratore
    4b Ambleside Avenue
    SW16 6AD Streatham
    London
    BritishManager74961830002
    FAHERTY, Janette Morag
    8 Brackendale
    Winchmore Hill
    N21 3DG London
    Amministratore
    8 Brackendale
    Winchmore Hill
    N21 3DG London
    EnglandBritishChief Executive7278060002
    FAHERTY, Matthew Augustine
    15 Selborne Road
    N14 7DD London
    Amministratore
    15 Selborne Road
    N14 7DD London
    BritishFinance Director34160310001
    JACOBI, Richard Samuel
    3 Poynter Road
    Bush Hill Park
    EN1 1DN Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    3 Poynter Road
    Bush Hill Park
    EN1 1DN Enfield
    Middlesex
    BritishManaging Director28630710002
    LEDGARD, Phillip Neil
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    England
    Amministratore
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    England
    EnglandUkFinance Director155892320001
    MARTIN, Colin William
    75a Canesworde Road
    LU6 3JL Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    75a Canesworde Road
    LU6 3JL Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant70167990001
    MOIR, Carol Ann
    26 Karen Way
    Great Sutton
    L66 4LL South Wirral
    Amministratore
    26 Karen Way
    Great Sutton
    L66 4LL South Wirral
    BritishCompany Director62574440002
    VERE, Stuart Peter
    Chester Road
    SW19 4TS London
    13
    Amministratore
    Chester Road
    SW19 4TS London
    13
    UkBritishDirector60434450001
    VINCINI, Salvo
    95 Chelmsford Road
    Southgate
    N14 5PY London
    Amministratore
    95 Chelmsford Road
    Southgate
    N14 5PY London
    BritishFinance Director71915670001
    WALKLEY, Stuart Richard
    The Old School Bowl Hill
    Kingscourt
    GL5 5DS Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Old School Bowl Hill
    Kingscourt
    GL5 5DS Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director52714390001
    WILLCOCKS, Jeffrey
    85 Brigadier Hill
    EN2 0NJ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    85 Brigadier Hill
    EN2 0NJ Enfield
    Middlesex
    BritishFinance Director42377290001
    ZACHARIADES, Aristos
    26 Hansler Road
    East Dulwich
    SE22 9DJ London
    Amministratore
    26 Hansler Road
    East Dulwich
    SE22 9DJ London
    BritishAccountant40539760001
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TNG LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peopleplus Group Limited
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    England
    06 apr 2016
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    19-20
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006 (Uk)
    Luogo di registrazioneUk (England And Wales) - Companies House
    Numero di registrazione05722765
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TNG LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 23 ott 2009
    Consegnato il 04 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The initial rent deposit being £15,000 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Communities & Local Government
    Transazioni
    • 04 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 ott 2009
    Consegnato il 21 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    £2,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The cash sum of £2,500 and all monies in connection thereof pursuant to a lease dated 13TH october 2009 relating to the ground floor west the sail loft limehouse court 3-11 dod street london E14 7EQ.
    Persone aventi diritto
    • Rock Jv (Number 1) Limited
    Transazioni
    • 21 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 12 ott 2009
    Consegnato il 02 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent & Trustee)
    Transazioni
    • 02 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent security deposit deed
    Creato il 03 set 2009
    Consegnato il 05 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £6,169 and the amount from time to time standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Catermater Limited
    Transazioni
    • 05 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Dilapidations deposit deed
    Creato il 07 ago 2009
    Consegnato il 15 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interest in the bank account in which the dilapidations deposit monies are placed see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • LCP Securities Limited
    Transazioni
    • 15 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 26 mar 2008
    Consegnato il 09 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    £2,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The companys interest in a designated interest bearing deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Rock Jv (Number 1) Limited
    Transazioni
    • 09 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 dic 2006
    Consegnato il 02 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £15,000 and all other monies payable under the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Communities and Local Government
    Transazioni
    • 02 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 24 ago 2006
    Consegnato il 25 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    £6,573.12 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    The greater of the sum of £6,573.12 or six months rent as defined in the rent deposit deed dated 24 august 2006.
    Persone aventi diritto
    • Aw Group Limited
    Transazioni
    • 25 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 giu 2006
    Consegnato il 13 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    £4,500.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    Rent deposit of £4,500.00.
    Persone aventi diritto
    • Shearwater Insurance Services Limited
    Transazioni
    • 13 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 feb 1996
    Consegnato il 20 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks Plcas Trustee for Itself and Aib Finance Limited
    Transazioni
    • 20 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Merinwell Limited
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 lug 1993
    Consegnato il 22 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the company's undertaking and all its property and assets including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merinwell Limited
    Transazioni
    • 22 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0