Q.C. SUPPLIES LIMITED
Panoramica
Nome della società | Q.C. SUPPLIES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02796130 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di Q.C. SUPPLIES LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di altre macchine e apparecchiature per ufficio (46660) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova Q.C. SUPPLIES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Arrowhead Park Arrowhead Road Theale RG7 4AH Reading |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di Q.C. SUPPLIES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per Q.C. SUPPLIES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Notifica di Quarry Court Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Duncan Gavin Forsyth il 31 gen 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Westcoast (Holdings) Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Cessazione di Westcoast (Holdings) Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 45 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015 | 23 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 03 dic 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
|
Chi sono gli amministratori di Q.C. SUPPLIES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORSYTH, Duncan Gavin | Amministratore | Arrowhead Road Theale RG7 4AH Reading Arrowhead Park Berkshire United Kingdom | England | British | Company Director | 108380160014 | ||||
MADHANI, Sunil Jayantilal | Amministratore | Arrowhead Road Theale RG7 4AH Reading Arrowhead Park England | England | British | Director | 101754170002 | ||||
CLAVERING, Robert John | Segretario | Crew-Yard House Water Lane, Stainby NG33 5QZ Grantham Lincolnshire | British | Director | 44835920001 | |||||
PALMER, Lynne Barker | Segretario | Lane Ends Midgehole HX7 7AL Hebden Bridge West Yorkshire | British | Company Director | 33735080001 | |||||
AA COMPANY SERVICES LIMITED | Segretario nominato | First Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002630001 | |||||||
CLAVERING, Robert John | Amministratore | Crew-Yard House Water Lane, Stainby NG33 5QZ Grantham Lincolnshire | England | British | Accountant | 44835920001 | ||||
CRABTREE, Jon Richard | Amministratore | Ellen Royd Ellen Royd Lane, Midgley Luddendenfoot HX2 6XE Halifax West Yorkshire | England | British | Entrepreneur | 39054630003 | ||||
CRABTREE, Tracey Louise | Amministratore | Ellen Royd Ellen Royd Lane, Midgley Luddendenfoot HX2 6XE Halifax West Yorkshire | British | Company Director | 58695060002 | |||||
PALMER, Lynne Barker | Amministratore | Lane Ends Midgehole HX7 7AL Hebden Bridge West Yorkshire | British | Company Director | 33735080001 | |||||
PALMER, Rodney | Amministratore | Lane Ends Midgehole Hebdon Bridge HX7 7AL Halifax West Yorkshire | British | 14581460001 | ||||||
BUYVIEW LTD | Amministratore delegato nominato | 1st Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002620001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di Q.C. SUPPLIES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarry Court Holdings Limited | 06 apr 2016 | Arrowhead Road Theale RG7 4AH Reading Arrowhead Park England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quarry Court Holdings Limited | 06 apr 2016 | Arrowhead Road Theale RG7 4AH Reading Arrowhead Park Berks England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Q.C. SUPPLIES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture | Creato il 30 set 2011 Consegnato il 04 ott 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage made between the company & john richard crabtree & tracey louise crabtree (1) & the bank (2) the said john richard crabtree & tracey louise crabtree charging as trustees of the q c supplies limited retirement benefits scheme | Creato il 23 apr 1998 Consegnato il 12 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee provided that the total amount recoverable in relation thereto under this mortgage shall not exceed an amount equal to the 40% share of the company in the proceeds of sale of the mortgaged property | |
Brevi particolari F/H property k/a 1.3 acres of land on the north east side of beacon hill road southowram halifax west yorkshire t/no: WYK310665. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 19 mar 1998 Consegnato il 30 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture deed | Creato il 05 mar 1998 Consegnato il 11 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 14 mag 1997 Consegnato il 17 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease and/or this deed | |
Brevi particolari All interest in the account and the deposit balance and all money withdrawn from the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 mag 1994 Consegnato il 20 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0