CANON GARTH LIMITED

CANON GARTH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCANON GARTH LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02800454
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CANON GARTH LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi (46390) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova CANON GARTH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CANON GARTH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FORMINCOME LIMITED17 mar 199317 mar 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di CANON GARTH LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2022
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2023
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CANON GARTH LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al15 dic 2022
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma29 dic 2022
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al15 dic 2021
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CANON GARTH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Cessazione della carica di Teunis Snoek come amministratore in data 30 ott 2024

    1 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    32 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    35 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 028004540021

    5 pagineMR05

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    12 pagineAM02

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOC

    4 pagineAM02

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOC

    4 pagineAM02

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOC

    4 pagineAM02

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    12 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    47 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da Alexander House 31-39 London Road Sevenoaks Kent TN13 1AR a Centre Block 4th Floor Central Court Knoll Rise Orpington BR6 0JA in data 31 ago 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    5 pagineAM01

    Cessazione della carica di Maximo Doukkali come amministratore in data 27 lug 2022

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2021 al 30 giu 2022

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Teunis Snoek il 15 feb 2022

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Mr Teunis Snoek come persona con controllo significativo il 15 feb 2022

    2 paginePSC04

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    34 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 028004540022, creata il 26 mag 2021

    34 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di CANON GARTH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KELMAN, David James
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Amministratore
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    United KingdomBritishCommercial Manager158426530001
    SNOEK, Jamie Oliver
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Alexander House
    Kent
    England
    Amministratore
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Alexander House
    Kent
    England
    EnglandDutchSales Trader157991850001
    SNOEK, Nicholas Aarjan
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Amministratore
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    United KingdomBritishProject Manager270677670001
    BELLWOOD, David Dean
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    BritishChartered Accountant51609320001
    CONNOR, John
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    Segretario
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    BritishFinance Director96761630002
    GILBERT, Richard
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    181201690001
    JORDAN, Peter Christopher
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    162436820001
    RHODES, Kevin John
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    190135240001
    THORNTON, Richard
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    Segretario
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    BritishCompany Secretary100268930001
    WHITE, Gary Martin
    24 Lytchett Way
    Upton
    BH16 5LS Poole
    Dorset
    Segretario
    24 Lytchett Way
    Upton
    BH16 5LS Poole
    Dorset
    British34082910001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BELLWOOD, David Dean
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishNon Exec51609320001
    CALKIN, Peter Shand
    The Malthouse
    Donhead
    SP7 9DN Shaftesbury
    Dorset
    Amministratore
    The Malthouse
    Donhead
    SP7 9DN Shaftesbury
    Dorset
    BritishMerchant5789260001
    COMPTON, Christopher Michael
    107 The Highway
    Chelsfield
    BR6 9DQ Orpington
    Kent
    Amministratore
    107 The Highway
    Chelsfield
    BR6 9DQ Orpington
    Kent
    EnglandBritishCompany Director11552100001
    CONNOR, John
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    Amministratore
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    BritishFinance Director96761630002
    DOUKKALI, Maximo
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishProject Manager191551590001
    GILBERT, Richard
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant86461880001
    GREEF, David
    84 Ridgeway Crescent
    BR6 9QP Orpington
    Kent
    Amministratore
    84 Ridgeway Crescent
    BR6 9QP Orpington
    Kent
    United KingdomBritishDirector107534040001
    HARRIS, Catherine Jane
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishLogistics Director190995710001
    JORDAN, Peter Christopher
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishFinance Director162435450001
    READ, Michael James
    122 London Road
    TN13 1BA Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    122 London Road
    TN13 1BA Sevenoaks
    Kent
    AustralianTechnical59081030002
    SNOEK, Teunis
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Amministratore
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    United KingdomDutchCompany Director83274220007
    THORNTON, Richard
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    Amministratore
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    EnglandBritishCompany Director100268930001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CANON GARTH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Continental Trade And Commodity Services Limited
    London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Alexander House
    England
    06 apr 2016
    London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Alexander House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies In England And Wales
    Numero di registrazione01315953
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Teunis Snoek
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    06 apr 2016
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    No
    Nazionalità: Dutch
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    CANON GARTH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 mag 2021
    Consegnato il 27 mag 2021
    In corso
    Breve descrizione
    None.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kimura Commodity Trade Finance Fund Limited
    Transazioni
    • 27 mag 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 lug 2018
    Consegnato il 30 lug 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wyelands Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 lug 2023Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 06 lug 2018
    Consegnato il 10 lug 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kimura Master Fund Limited
    Transazioni
    • 10 lug 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 ago 2013
    Consegnato il 11 set 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • British Arab Commercial Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 ago 2013
    Consegnato il 09 set 2013
    In corso
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • British Arab Commercial Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 04 ago 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    First party charge over credit balances
    Creato il 16 giu 2010
    Consegnato il 23 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies from time to time held to the credit of the mortgagor by the bank on any current deposit or other account or accounts or under any deposit receipt.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 23 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Trade finance security agreement
    Creato il 10 mar 2010
    Consegnato il 31 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge over all moneys , other receivables policies and contracts of insurance, hypothecation of goods and documents see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas (Suisse Sa)
    Transazioni
    • 31 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 18 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Account charge
    Creato il 04 gen 2006
    Consegnato il 23 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit and all right title and interest in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank N.V. London Branch
    Transazioni
    • 23 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2006
    Consegnato il 21 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of receivables
    Creato il 04 gen 2006
    Consegnato il 20 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights under any contracts any breach of any contract under any policy of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank N.V London Branch
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 apr 2003
    Consegnato il 13 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital, stocks, shares, copyrights, patents, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv, London Branch
    Transazioni
    • 13 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Collection account charge
    Creato il 24 apr 2003
    Consegnato il 13 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The right, title and interest in the deposit.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank N.V. London Branch
    Transazioni
    • 13 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    General charge of receivables and contract rights
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 16 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's right title benefits and interest in and to all monies payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Absa Bank Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 16 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Absa Bank Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ott 2001
    Consegnato il 16 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility letter dated 19TH december 1997 and the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property assets and rights present and future including plant machinery and equipment debts goodwill uncalled capital intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.
    Transazioni
    • 16 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of general pledge, hypothecation and charge
    Creato il 28 set 2001
    Consegnato il 05 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1).All goods and produce delivered into the actual or constructive possession of ing bank N.V. london branch and all goods financed by the bank through documentary credit or other transaction 2). all bills of lading, receipts or other documents relating to the goods described in (1) above and which are delivered into the actual or constructive possession of the bank 3). the proceeds of sale of any of the goods or documents described in (1) or (2) above 4). all contracts entered into by the company with respect to any goods which have been financed by the bank (including all letter of credit guarantees and contracts of insurance opened or issued with respect to such goods).
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transazioni
    • 05 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 feb 2000
    Consegnato il 15 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility letter dated 19/12/97 and the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 15 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 gen 1999
    Consegnato il 09 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "$10,000,000 facility letter" dated 8TH december 1998 between the company and the borrower as amended varied novated supplemented or replaced and the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und-Vereinsbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 09 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General letter of pledge,hypothecation and charge
    Creato il 09 feb 1998
    Consegnato il 16 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All goods and produce delivered into the actual or constructive possession of the bank and all goods financed by the bank all bills receipts or other documents proceeds of sale all contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 16 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CANON GARTH LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 ago 2022Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Benjamin Stanyon
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Praticante
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Nedim Patrick Ailyan
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Praticante
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0