MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED

MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02801072
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    • Altre attività di pubblicazione di software (58290) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE FRUSTUM GROUP (EUROPE) LIMITED18 mar 199318 mar 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 01 apr 2015

    • Capitale: USD 3,890,770
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mar 2015

    Stato del capitale al 27 mar 2015

    • Capitale: USD 6,900
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2014

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Paul Woodward come amministratore in data 05 set 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sanjay Patel come amministratore in data 28 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Van Harken come amministratore in data 31 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Mary Collins come amministratore in data 31 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2014

    Stato del capitale al 24 mar 2014

    • Capitale: USD 6,900
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2013

    11 pagineAA

    Nomina di Mrs Elizabeth Mary Collins come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Misys Corporate Director Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joanna Hawkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Misys Corporate Secretary Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Sanjay Patel come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Joanna Marageret Hawkes come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bijal Patel come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Edward Timothy Homer il 20 mag 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mag 2012

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Nicholas Farrimond come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Bijal Mahendra Patel come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    BAINS, Gurbinder
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Other138753780001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    STOKOE, Anthony
    4 Clifton Road
    KT2 6PW Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    4 Clifton Road
    KT2 6PW Kingston Upon Thames
    Surrey
    British29734520002
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Segretario
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione07036299
    149996410001
    SECORP LIMITED
    PO BOX 556, Hunkins Waterfront
    Plaza, Main Street
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    Segretario
    PO BOX 556, Hunkins Waterfront
    Plaza, Main Street
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    93219460001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    DARBY, Andrew Hamish
    9a Oatlands Chase
    KT13 9RF Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    9a Oatlands Chase
    KT13 9RF Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish114800800001
    DAVIS, Steven Rogers
    71 Gerrish Lane
    New Canaan
    Connecticut
    06840
    Usa
    Amministratore
    71 Gerrish Lane
    New Canaan
    Connecticut
    06840
    Usa
    United StatesAmerican42813140002
    DEMETRIOS, Helen
    316 Stonehill Road
    10576 Pound Ridge
    New York
    United States
    Amministratore
    316 Stonehill Road
    10576 Pound Ridge
    New York
    United States
    American34271630002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    Amministratore
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    EnglandBritish75357260001
    FLOCK, Charles
    42 West Clinton Avenue
    10533 Irvington
    New Yok
    United States Of America
    Amministratore
    42 West Clinton Avenue
    10533 Irvington
    New Yok
    United States Of America
    American34271860002
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HELSBY, Frank Peter
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish34237710003
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Amministratore
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    JAUFERING, Robert Russell
    5 Monck Street
    SW1P 2BW London
    Amministratore
    5 Monck Street
    SW1P 2BW London
    American37636270001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    PEDDAR, Richard Granville
    14 Lower Common South
    Putney
    SW15 1BP London
    Amministratore
    14 Lower Common South
    Putney
    SW15 1BP London
    British57803270001
    SOMMERS, Gary
    10 Shoshone Drive
    10526 Golders Bridge
    New York
    United States
    Amministratore
    10 Shoshone Drive
    10526 Golders Bridge
    New York
    United States
    American34272070002
    SPADAFORA, Fred Jphn
    3 Heathview Court
    Corringway
    NW11 7EF London
    Amministratore
    3 Heathview Court
    Corringway
    NW11 7EF London
    American52601930001
    STADTHER, Michael
    316 Stonehill Road
    10576 Pound Ridge
    New York
    United States
    Amministratore
    316 Stonehill Road
    10576 Pound Ridge
    New York
    United States
    American34271760002
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    WHITE, Andrew Ian
    Hillcott
    Perrotts Brook
    GL7 7BN Cirencester
    Glos
    Amministratore
    Hillcott
    Perrotts Brook
    GL7 7BN Cirencester
    Glos
    United KingdomBritish93602410001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    Amministratore
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    82836510002

    MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 12 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creato il 23 ott 2002
    Consegnato il 13 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Creato il 09 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0