PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02801424 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Liverpool Terrace BN11 1TA Worthing |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 ago 2022 | 14 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10 New Burlington Street (6th Floor) New Burlington Street London W1S 3BE a 1 Liverpool Terrace Worthing BN11 1TA in data 07 set 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2019, non revisionato | 8 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2018, non revisionato | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2017, non revisionato | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio modificato redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AAMD | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2016, non revisionato | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John David Hopkins come segretario in data 19 giu 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Mike Pashley come amministratore in data 31 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN, William Stephen | Amministratore | Liverpool Terrace BN11 1TA Worthing 1 | United Kingdom | American | 71600980005 | |||||
| ROBERTSON, John Manwaring | Amministratore | Liverpool Terrace BN11 1TA Worthing 1 | England | British | 23497540002 | |||||
| DUZNIAK, Jadzia Zofia | Segretario | 8 Chapman Square Parkside Wimbledon SW19 5QQ London | British | 66314480005 | ||||||
| DUZNIAK, Jadzia Zofia | Segretario | 8 Chapman Square Parkside Wimbledon SW19 5QQ London | British | 66314480005 | ||||||
| HOPKINS, John David | Segretario | New Burlington Street W1S 3BE London 10 New Burlington Street (6th Floor) England | British | 114264270002 | ||||||
| LAWS, Sarah Caroline | Segretario | 33 Kingscote Road Chiswick W4 5LJ London | British | 11859980002 | ||||||
| MEECH, Christopher Michael | Segretario | 110 Haslemere Road GU30 7BU Liphook Hampshire | British | 2721270001 | ||||||
| PALIN, Dion Bradley | Segretario | 76c Gascony Avenue West Hampstead NW6 4NE London | Australian | 118184720001 | ||||||
| PARKINSON, Paul Talbot | Segretario | 4 Swift Street SW6 5AG London | English | 79734240001 | ||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Segretario nominato | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003220001 | |||||||
| BECKWITH, John Lionel, Sir | Amministratore | 55 Campden Hill Road Kensington W8 7DY London | United Kingdom | British | 1017520002 | |||||
| BLENKO, Don Balman | Amministratore | 27 Burlington Gardens W4 4LT London | Usa | Uk Us | 45456900001 | |||||
| BOWES, Graham John | Amministratore | Greenbanks Pewley Point Pewley Hill GU1 3SP Guildford Surrey | British | 37707190002 | ||||||
| DUZNIAK, Jadzia Zofia | Amministratore | 8 Chapman Square Parkside Wimbledon SW19 5QQ London | United Kingdom | British | 66314480005 | |||||
| DUZNIAK, Jadzia Zofia | Amministratore | 8 Chapman Square Parkside Wimbledon SW19 5QQ London | United Kingdom | British | 66314480005 | |||||
| GRAHAM, Charles Ian Macgregor | Amministratore | 95 Mallinson Road SW11 8LB London | United Kingdom | British | 36804410003 | |||||
| HODDELL, Christopher James | Amministratore | 95 Home Park Road Wimbledon SW19 7HT London | United Kingdom | British | 2854480001 | |||||
| LAWS, Sarah Caroline | Amministratore | 33 Kingscote Road Chiswick W4 5LJ London | British | 11859980002 | ||||||
| MEECH, Christopher Michael | Amministratore | 110 Haslemere Road GU30 7BU Liphook Hampshire | United Kingdom | British | 2721270001 | |||||
| ORF, Roger Gerard | Amministratore | Pelham Crescent SW7 2NP London 1 | United Kingdom | British | 38079110001 | |||||
| PARKINSON, Paul Talbot | Amministratore | 4 Swift Street SW6 5AG London | England | English | 79734240001 | |||||
| PASHLEY, Mike | Amministratore | 19 Rothsay Road MK40 3PP Bedford Bedfordshire | England | British | 79734380002 | |||||
| SHEEHAN, Nicholas John Philip | Amministratore | Herons Farm Kirdford RH14 0ND Billingshurst West Sussex | British | 39476870002 | ||||||
| WALSH, David George Patrick | Amministratore | 8 Westmoreland Place SW1V 4AD London | United Kingdom | British | 11107290003 | |||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003220001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 03 mar 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security deposit charge | Creato il 28 feb 2003 Consegnato il 07 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of fixed charge its interest in the account and all money as at the date of the security deposit charge, standing to the credit of the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Subordination deed | Creato il 28 feb 2003 Consegnato il 05 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys,obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All present and future sums,liabilities and obligations payable or owing by any of the obligors to any subordinated creditor,as defined; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Shares charge | Creato il 17 gen 2002 Consegnato il 21 gen 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of fixed charge:- (a) the investments, and (b) all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Creato il 24 ago 1999 Consegnato il 27 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Subordination deed between staffordshire securities limited (the "borrower"), the company and rheinhyp rheinische hypothekenbank ag (frankfurt office)(the "bank") | Creato il 21 gen 1999 Consegnato il 21 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by an obligor or by some other person) of each obligor to the chargee under each of the finance documents (the "senior liabilities") | |
Brevi particolari The company as the junior creditor under the subordination deed has undertaken to the bank it will (if the junior creditor concerned actually receives the amount discharged or purported to be discharged) hold the same upon trust of the bank for application in or towards payment of all the senior liabilities and will promptly pay the same to the bank; (see form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 15 ott 1998 Consegnato il 22 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date | |
Brevi particolari £47,833.00 and all money from time to time withdrawn from the deposit. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment agreement | Creato il 05 apr 1994 Consegnato il 09 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility agreement dated 26 january 1994 | |
Brevi particolari All present and future right,title and interest including (without limitation) all monies now or at any time in the future under an interest rate cap transaction between midaln bank PLC and the company dated 31 january 1994. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0