CA 2010 PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCA 2010 PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 02808331
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CA 2010 PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova CA 2010 PLC?

    Indirizzo della sede legale
    The Valley
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CA 2010 PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHARLTON ATHLETIC PLC06 gen 199406 gen 1994
    YPCS 25 P.L.C.13 apr 199313 apr 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di CA 2010 PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CA 2010 PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Richard Hatter come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David White come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sale of entire iss share cap/sec 190(1) 23/08/2010
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed charlton athletic PLC\certificate issued on 10/09/10
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 ago 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Cessazione della carica di Derek Chappell come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Hughes come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Whitehand come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Sumners come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Stephen Kavanagh come amministratore

    3 pagineAP01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 ago 2010

    • Capitale: GBP 31,947,961.5
    8 pagineSH01

    Bilancio annuale redatto al 13 apr 2010 con elenco di azionisti in blocco

    26 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Alan Murray Obodynski il 15 gen 2010

    3 pagineCH01

    legacy

    pagineANNOTATION

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Re section 560 ca 2006 30/12/2009
    RES13

    Chi sono gli amministratori di CA 2010 PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VERTEX LAW (CO SECRETARIAL) LIMITED
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UD West Malling
    23
    Kent
    Segretario
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UD West Malling
    23
    Kent
    102565320003
    BUTLER-GALLIE, Stuart
    Bethersden
    TN26 3EW Ashford
    Baylisden House
    Kent
    Amministratore
    Bethersden
    TN26 3EW Ashford
    Baylisden House
    Kent
    EnglandBritish96783000001
    KAVANAGH, Stephen Andrew
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    The Valley
    Amministratore
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    The Valley
    EnglandBritish153739440001
    MURRAY OBODYNSKI, Richard Alan
    66-70 Coombe Road
    KT3 4QW New Maldon
    Nunn Hayward
    Surrey
    Amministratore
    66-70 Coombe Road
    KT3 4QW New Maldon
    Nunn Hayward
    Surrey
    EnglandBritish46792500008
    FULLER, Jonathan Tom Telford
    Rose Cottage
    Twitton Lane
    TN14 5JS Otford
    Kent
    Segretario
    Rose Cottage
    Twitton Lane
    TN14 5JS Otford
    Kent
    British52304380001
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    Segretario
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    British8282250001
    BRACHERS LIMITED
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    Segretario
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    80957680001
    DAVIES LAVERY COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    Segretario
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    87634940001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    ALWEN, Roger Norman
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    Amministratore
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    British14306470002
    BONE, Gregory Peter
    17 Brassey Hill
    Limpsfield
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    Amministratore
    17 Brassey Hill
    Limpsfield
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    British26854940002
    CHAPPELL, Derek Guy
    13 Walton Place
    SW3 1RJ London
    Amministratore
    13 Walton Place
    SW3 1RJ London
    EnglandBritish32697520004
    CLARKE, Stephen Thomas
    20 Porcupine Close
    Mottingham
    SE9 3AE London
    Amministratore
    20 Porcupine Close
    Mottingham
    SE9 3AE London
    United KingdomBritish33772930001
    COLLINS, Richard Denis
    33b Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    Amministratore
    33b Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    British1811300001
    FRANKLIN, Gideon Benjamin Cecil
    22 Ringmore Rise
    SE23 3DE London
    Amministratore
    22 Ringmore Rise
    SE23 3DE London
    United KingdomBritish69257060003
    GRADE, Michael Ian
    6 Westover Road
    SW18 2RG London
    Amministratore
    6 Westover Road
    SW18 2RG London
    EnglandBritish71289920004
    HALLETT, Brian James
    39 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    39 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish9715270001
    HATTER, Maurice, Sir
    38 Queens Grove
    NW8 6HH London
    Amministratore
    38 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritish36506710001
    HATTER, Richard Mark
    Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UJ London
    54
    Amministratore
    Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UJ London
    54
    EnglandEnglish67030840002
    HUGHES, David John
    Sterling Street
    SW7 1HN London
    8
    Amministratore
    Sterling Street
    SW7 1HN London
    8
    EnglandBritish49400910005
    HUGHES, David John
    Vitol Sa
    Bowater House 68 Knightsbridge
    SW1X 7LT London
    Amministratore
    Vitol Sa
    Bowater House 68 Knightsbridge
    SW1X 7LT London
    British49400910001
    NORRIS, Craig Victor
    156 Humber Road
    Blackheath
    SE3 7EF London
    Amministratore
    156 Humber Road
    Blackheath
    SE3 7EF London
    British43819750002
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    Amministratore
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    United KingdomBritish8282250001
    SIMONS, Martin Alan
    48 Shooters Hill Road
    Blackheath
    SE3 7BG London
    Amministratore
    48 Shooters Hill Road
    Blackheath
    SE3 7BG London
    British15777410001
    STEVENS, Michael Clifford
    Northside 36 Southborough Road
    Bickley
    BR1 2EB Bromley
    Kent
    Amministratore
    Northside 36 Southborough Road
    Bickley
    BR1 2EB Bromley
    Kent
    British25614630001
    SUMNERS, David Colin, Dr
    The Old Vicarage
    2 Mountfort Crescent
    N1 1JW London
    Amministratore
    The Old Vicarage
    2 Mountfort Crescent
    N1 1JW London
    United KingdomBritish47150540002
    UFTON, Derek Gilbert
    88 Madeira Avenue
    BR1 4AS Bromley
    Kent
    Amministratore
    88 Madeira Avenue
    BR1 4AS Bromley
    Kent
    British15366180001
    WHITE, David
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    The Briars
    Kent
    Amministratore
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    The Briars
    Kent
    United KingdomBritish138647910001
    WHITEHAND, Robert Charles
    Dunstall Priory Shoreham Road
    Shoreham
    TN14 7UE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Dunstall Priory Shoreham Road
    Shoreham
    TN14 7UE Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish54419430001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001

    CA 2010 PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 25 set 2009
    Consegnato il 29 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • David Hughes
    Transazioni
    • 29 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 25 set 2009
    Consegnato il 29 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • David Sumners
    Transazioni
    • 29 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009
    Debenture
    Creato il 25 set 2009
    Consegnato il 29 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • David White
    Transazioni
    • 29 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 giu 2009
    Consegnato il 26 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sir Maurice Hatter
    Transazioni
    • 26 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 mar 2009
    Consegnato il 20 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Richard Alan Murray
    Transazioni
    • 20 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 mar 2009
    Consegnato il 14 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derek Chappell
    Transazioni
    • 14 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 mar 2009
    Consegnato il 14 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • 56 Developments LLP
    Transazioni
    • 14 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 mar 2008
    Consegnato il 08 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the to the bondholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Richard Alan Murray and Derek Chappell
    Transazioni
    • 08 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 dic 2007
    Consegnato il 10 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Richard Alan Murray
    Transazioni
    • 10 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mag 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bolistrom Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mag 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sir Maurice Hatter
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mag 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • David Colin Sumners
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mag 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert Charles Whitehand
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mag 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derek Chappell
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 mag 1999
    Consegnato il 03 giu 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 mar 1999
    Consegnato il 13 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the property; fixed charge over f/h & l/h property both present and future together with all fixtures and its goodwill; a floating charge over the undertaking and all its (other) property and assets whatsoever.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0