ARRIVEOBTAIN LIMITED

ARRIVEOBTAIN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARRIVEOBTAIN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02810421
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARRIVEOBTAIN LIMITED?

    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova ARRIVEOBTAIN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    75b Verde
    10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARRIVEOBTAIN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per ARRIVEOBTAIN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    12 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Hudsons Place London SW1V 1PZ a 75B Verde 10 Bressenden Place London SW1E 5DH in data 11 ott 2016

    1 pagineAD01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 29 set 2016

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2016

    Stato del capitale al 13 gen 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2015

    Stato del capitale al 28 gen 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Adam Maxwell Jones come amministratore in data 28 mar 2014

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas John Candler il 01 nov 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 03 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 gen 2014

    Stato del capitale al 27 gen 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Dettagli del segretario cambiati per Clive Edward Benedict Schlee il 07 gen 2013

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas John Candler il 07 gen 2013

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di ARRIVEOBTAIN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCHLEE, Clive Edward Benedict
    Verde
    10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    75b
    England
    Segretario
    Verde
    10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    75b
    England
    British88506560001
    CANDLER, Nicholas John
    Verde
    10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    75b
    England
    Amministratore
    Verde
    10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    75b
    England
    EnglandBritish129758090001
    JONES, Adam Maxwell
    Verde
    10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    75b
    England
    Amministratore
    Verde
    10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    75b
    England
    United KingdomBritish124674500006
    SCHLEE, Clive Edward Benedict
    Verde
    10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    75b
    England
    Amministratore
    Verde
    10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    75b
    England
    United KingdomBritish88506560001
    CLARK, John Robert Morton
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    Segretario
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    British79328330001
    GEORGE, Nicholas David
    Mallows Wood Stony Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DS Great Missenden
    Bucks
    Segretario
    Mallows Wood Stony Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DS Great Missenden
    Bucks
    British11794040001
    SMYTH, Harvey John
    Flat L 54 Cornwall Gardens
    SW7 4BG London
    Segretario
    Flat L 54 Cornwall Gardens
    SW7 4BG London
    British74178000001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEECHAM, Sinclair Christopher Seymour
    22 Painters Yard
    10-14 Old Church Road
    SW3 5DQ London
    Amministratore
    22 Painters Yard
    10-14 Old Church Road
    SW3 5DQ London
    United KingdomBritish169916050001
    CLARK, John Robert Morton
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    Amministratore
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    EnglandBritish79328330001
    GEORGE, Nicholas David
    Mallows Wood Stony Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DS Great Missenden
    Bucks
    Amministratore
    Mallows Wood Stony Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DS Great Missenden
    Bucks
    British11794040001
    GREEN, Jeremy
    10 Prairie Street
    SW8 3PU London
    Amministratore
    10 Prairie Street
    SW8 3PU London
    British43113670001
    METCALFE, Julian Edward
    High Lodge
    Blenheim Park
    OX7 2NE Whitney
    Oxfordshire
    Amministratore
    High Lodge
    Blenheim Park
    OX7 2NE Whitney
    Oxfordshire
    British43805380002
    METCALFE, Julian Edward
    High Lodge
    Blenheim Park
    OX7 2NE Whitney
    Oxfordshire
    Amministratore
    High Lodge
    Blenheim Park
    OX7 2NE Whitney
    Oxfordshire
    British43805380002
    ROLFE, Andrew John
    5 The Vale
    SW3 6AG London
    Amministratore
    5 The Vale
    SW3 6AG London
    British South African51146460003
    SLADE, Benjamin Julian Alfred, Sir
    Flat 3
    332 Kings Road
    SW3 5UR London
    Amministratore
    Flat 3
    332 Kings Road
    SW3 5UR London
    British48986730004
    SMYTH, Harvey John
    Flat L 54 Cornwall Gardens
    SW7 4BG London
    Amministratore
    Flat L 54 Cornwall Gardens
    SW7 4BG London
    British74178000001
    TOLNER, Mark Richard
    Manor Heights Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Manor Heights Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British55346110002
    WITHALL, Mark Trevor
    101 Pearl Gardens
    Cippenham
    SL1 2YX Slough
    Berkshire
    Amministratore
    101 Pearl Gardens
    Cippenham
    SL1 2YX Slough
    Berkshire
    EnglandBritish68419500001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ARRIVEOBTAIN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An amendment deed, amending a debenture dated 23RD march 2000
    Creato il 20 feb 2004
    Consegnato il 03 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to barclays bank PLC as trustee for itself and hsbc bank PLC (each a 'beneficiary') under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC and Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A pari passu deed made between barclays bank PLC acting as security trustee for itself and on behalf of hsbc bank PLC (the "security trustee"),hsbc bank PLC,the company,pret a manger (usa) limited,pret a manger (europe) limited and pret a manger (netherlands) limited (the "deed") creating certain trust relationships
    Creato il 23 mar 2000
    Consegnato il 06 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The security trustee confirms that it holds the security documents and the security thereby constituted and the undertakings therein contained and that it shall exercise the powers duties discretion's and authorities conferred by the facilities documentation and the security documents together with such powers as are reasonably incidental thereto upon trust for each of the finance parties (as defined in the facilities agreement) and apply all payments and other benefits received by it by reason thereof or otherwise realised thereunder in accordance with the provisions of the facilities agreement and the security documents (all as defined)
    Brevi particolari
    Under the deed,the parties agree that any recoveries shall be applied in accordance with this deed,where recoveries are defined as "the net proceeds of any realisation or disposal of,or recovery of or from,the whole or any part of the property,assets or undertaking of any group member (including the net proceeds of any realisation,disposal or recovery under the security documents and any dividend received in the liquidation of any group member and the benefit of any combination or consolidation of accounts of or set-off or netting exercised against any group member.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC Acting as Security Trustee
    Transazioni
    • 06 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 mar 2000
    Consegnato il 03 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 dic 1998
    Consegnato il 24 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 14 set 1996
    Consegnato il 20 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit agreement
    Creato il 30 giu 1995
    Consegnato il 05 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date
    Brevi particolari
    The interest of the company in the rent deposit account and all money from time to time withdrawn from the rent deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Signet Group PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 12 ago 1994
    Consegnato il 20 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of the tenant under the lease or this deed
    Brevi particolari
    Ground and first floors,8/10 king st,london W.6; the sum of £88,125 standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Underwoods (Cash Chemists) Limited
    Transazioni
    • 20 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0