TECH123 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTECH123 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02814155
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TECH123 LIMITED?

    • (7220) /
    • (7310) /
    • (7420) /

    Dove si trova TECH123 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KROLL LIMITED
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TECH123 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NALLATECH LIMITED30 apr 199330 apr 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di TECH123 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per TECH123 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 ott 2010

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 apr 2010

    5 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    14 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    19 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    18 pagine2.17B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di TECH123 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GILCHRIST, John
    The Chimes
    7 Birkdale Wood, Westerwood
    G68 0GY Cumbernauld
    Amministratore
    The Chimes
    7 Birkdale Wood, Westerwood
    G68 0GY Cumbernauld
    Gb-SctScottish100819670001
    CANTLE, Sarah Caroline
    17 Gullane Crescent Westerwood
    Cumbernauld
    G68 0HR Glasgow
    Segretario
    17 Gullane Crescent Westerwood
    Cumbernauld
    G68 0HR Glasgow
    British43723390001
    FREELAND, George Keith
    37 Ravelrig Gait
    EH14 7NH Balerno
    Midlothian
    Segretario
    37 Ravelrig Gait
    EH14 7NH Balerno
    Midlothian
    British809960009
    GILCHRIST, John
    The Chimes
    7 Birkdale Wood, Westerwood
    G68 0GY Cumbernauld
    Segretario
    The Chimes
    7 Birkdale Wood, Westerwood
    G68 0GY Cumbernauld
    Scottish100819670001
    NICHOLSON, Andrew Graham
    54 Claremont Gardens
    BS21 5BH Clevedon
    Avon
    Segretario
    54 Claremont Gardens
    BS21 5BH Clevedon
    Avon
    British34197110002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDERSON, Craig Brian
    6 Clarendon Crescent
    EH4 1PT Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    6 Clarendon Crescent
    EH4 1PT Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish110947160001
    CANTLE, Allan
    Flat 1 14 Percival Road
    Clifton
    BS8 3LN Bristol
    Amministratore
    Flat 1 14 Percival Road
    Clifton
    BS8 3LN Bristol
    British84570170002
    CANTLE, Sarah Caroline
    17 Gullane Crescent Westerwood
    Cumbernauld
    G68 0HR Glasgow
    Amministratore
    17 Gullane Crescent Westerwood
    Cumbernauld
    G68 0HR Glasgow
    British43723390001
    DEVLIN, Malachy, Dr
    32 Overtoun Drive
    Rutherglen
    G73 2QD Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    32 Overtoun Drive
    Rutherglen
    G73 2QD Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish52556120001
    FREELAND, George Keith
    37 Ravelrig Gait
    EH14 7NH Balerno
    Midlothian
    Amministratore
    37 Ravelrig Gait
    EH14 7NH Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritish809960009
    HUNT, Ian Spinks
    Oliver Villa
    Mayville Park
    EH42 1AH Dunbar
    East Lothian
    Amministratore
    Oliver Villa
    Mayville Park
    EH42 1AH Dunbar
    East Lothian
    ScotlandBritish82263970001
    LEWANDOWSKI, Kenneth Macdonald Arthur
    5 Allanwater Gardens
    Bridge Of Allan
    FK9 4DW Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    5 Allanwater Gardens
    Bridge Of Allan
    FK9 4DW Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish14010460001
    NICHOLSON, John Mcallister
    Hopton Farm House
    Hopton, Hodnet
    TF9 3LE Market Drayton
    Shropshire
    Amministratore
    Hopton Farm House
    Hopton, Hodnet
    TF9 3LE Market Drayton
    Shropshire
    British91072610002
    ROBERTSON, Iain Malcolm
    Merry Hills Cottage
    Merry Hills Lane
    RH14 0RB Loxwood
    West Sussex
    Amministratore
    Merry Hills Cottage
    Merry Hills Lane
    RH14 0RB Loxwood
    West Sussex
    United KingdomBritish30965630001
    RUTHERFORD, Colin
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish39515100002

    TECH123 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 17 apr 2008
    Consegnato il 25 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 25 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 apr 2008
    Consegnato il 25 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Sep Iib
    Transazioni
    • 25 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge debenture
    Creato il 17 apr 2008
    Consegnato il 25 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Sep Ii
    Transazioni
    • 25 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 19 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sep Iib
    Transazioni
    • 19 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 19 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 19 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sep Ii
    Transazioni
    • 19 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 25 mar 2007
    Consegnato il 07 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £15,000 credited to account designation 00104774 with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 feb 2006
    Consegnato il 10 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bridge Bank, National Association
    Transazioni
    • 10 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Intellectual property security agreement
    Creato il 22 feb 2006
    Consegnato il 01 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in to and under its intellectual property collateral including copyrights patents and trademarks being programmable power supply system patent no 6,897,677 method of providing power to field programmable gate array modules p/no 6,809,548 programmable power supply for field programmable gate array modules p/no 6,710,621 and techniques of using a high level programming language in defining functionality for programmable logic. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Etv Capital S.A.
    Transazioni
    • 01 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 22 feb 2006
    Consegnato il 25 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Etv Capital S.A
    Transazioni
    • 25 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 19 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 19 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sep Ii
    Transazioni
    • 19 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 19 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sep Ii B
    Transazioni
    • 19 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 ott 2003
    Consegnato il 24 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 02 october 2001 and
    Creato il 20 set 2001
    Consegnato il 05 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole the subjects known as and forming 1 napier park cumbernauld glasgow G67 title number DMB55463.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 set 2001
    Consegnato il 27 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TECH123 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 apr 2009Fine dell'amministrazione
    07 mag 2008Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Fraser James Gray
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Praticante
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DataTipo
    17 feb 2011Data di scioglimento
    29 apr 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Fraser James Gray
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Praticante
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0