THORN LIGHTING INTERNATIONAL

THORN LIGHTING INTERNATIONAL

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHORN LIGHTING INTERNATIONAL
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 02816411
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di THORN LIGHTING INTERNATIONAL?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova THORN LIGHTING INTERNATIONAL?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THORN LIGHTING INTERNATIONAL?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRAVELSIMPLE TRADING LIMITED10 mag 199310 mag 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di THORN LIGHTING INTERNATIONAL?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2003

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THORN LIGHTING INTERNATIONAL?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al10 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma24 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al10 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per THORN LIGHTING INTERNATIONAL?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Emanuel Hagspiel il 31 ago 2023

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Matthew James Boucher come amministratore in data 01 giu 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Emanuel Hagspiel come amministratore in data 01 giu 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Matthew James Boucher come amministratore in data 01 ott 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Leonard James Russell come amministratore in data 01 ott 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Paul Marcus Coggins come amministratore in data 08 mag 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Leonard James Russell come amministratore in data 08 mag 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Marcus Coggins come amministratore in data 28 giu 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip Oscar Widner come amministratore in data 28 giu 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Nomina di Christopher Colin Whitehead come segretario in data 12 set 2016

    2 pagineAP03
    Note
    DataNota
    02 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 02/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cessazione della carica di St John's Square Secretaries Limited come segretario in data 12 set 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2016

    Stato del capitale al 21 giu 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    Note
    DataNota
    15 feb 2022Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 15/02/2022 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mag 2015

    Stato del capitale al 12 mag 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    Note
    DataNota
    15 feb 2022Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 15/02/2022 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Nomina di Mr Philip Oscar Widner come amministratore in data 13 ott 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Martin Anton Brandt come amministratore in data 13 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mag 2014

    Stato del capitale al 27 mag 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    Note
    DataNota
    15 feb 2022Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 15/02/2022 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Dettagli del segretario cambiati per St John's Square Secretaries Limited il 28 giu 2013

    1 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di THORN LIGHTING INTERNATIONAL?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITEHEAD, Christopher Colin
    Butchers Race
    DL16 6HL Spennymoor
    Durhamgate
    County Durham
    Segretario
    Butchers Race
    DL16 6HL Spennymoor
    Durhamgate
    County Durham
    214650090001
    HAGSPIEL, Emanuel
    Butchers Race
    DL16 6HL Spennymoor
    Durhamgate
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Butchers Race
    DL16 6HL Spennymoor
    Durhamgate
    County Durham
    United Kingdom
    AustriaAustrianManaging Director Finance296892560002
    THOMSON, Claire Therese
    Butchers Race
    DL16 6HL Spennymoor
    Durhamgate
    County Durham
    Amministratore
    Butchers Race
    DL16 6HL Spennymoor
    Durhamgate
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant138670540001
    ASHWORTH, Christopher John
    30 Brookway
    Blackheath
    SE3 9BJ London
    Segretario
    30 Brookway
    Blackheath
    SE3 9BJ London
    BritishSolicitor34792280001
    BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    Segretario
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    BritishCompany Secretary63851130001
    HUTH, Johannes Peter
    26 Perrymead Street
    SW6 3SP London
    Segretario
    26 Perrymead Street
    SW6 3SP London
    GermanInvestment Banker35006520001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    49 Harlech Road
    Southgate
    N14 7BY London
    Segretario
    49 Harlech Road
    Southgate
    N14 7BY London
    BritishDirector39155140001
    STRINGER, David Michael
    36 Sherbourne Drive
    SL6 3EP Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    36 Sherbourne Drive
    SL6 3EP Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector13857160001
    THOMAS, Helen
    29 Rutherford Way
    WD23 1NJ Bushey Heath
    Herts
    Segretario
    29 Rutherford Way
    WD23 1NJ Bushey Heath
    Herts
    British125124890001
    WOODCOCK, Michael Alan
    96 Marlborough
    Walton Street
    SW3 2JY London
    Segretario
    96 Marlborough
    Walton Street
    SW3 2JY London
    British61723250001
    ST JOHN'S SQUARE SECRETARIES LIMITED
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    England
    Segretario
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01190758
    2469520012
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ASHWORTH, Christopher John
    30 Brookway
    Blackheath
    SE3 9BJ London
    Amministratore
    30 Brookway
    Blackheath
    SE3 9BJ London
    BritishSolicitor34792280001
    ASKARI, Mamoun
    Flat 1
    66 Cadogan Square
    SW1X 0EA London
    Amministratore
    Flat 1
    66 Cadogan Square
    SW1X 0EA London
    BritishInvestment Banker81751240001
    BOUCHER, Matthew James
    Copthall Road West
    Ickenham
    UB10 8HT Uxbridge
    97
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Copthall Road West
    Ickenham
    UB10 8HT Uxbridge
    97
    Middlesex
    England
    EnglandBritishManaging Director251480640001
    BRANDT, Martin Anton
    Raueneggstrabe 43
    88212 Ravensburg
    -
    Germany
    Amministratore
    Raueneggstrabe 43
    88212 Ravensburg
    -
    Germany
    GermanyGermanChief Operating Officer155083030002
    BRYCE, Robert Donaldson Hamish
    Trean
    The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Trean
    The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Hertfordshire
    BritishDirector2661060001
    BUSCOMBE, Philip John
    The Ferry House Ferry Lane
    Goring On Thames
    RG8 9DX Reading
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Ferry House Ferry Lane
    Goring On Thames
    RG8 9DX Reading
    Oxfordshire
    EnglandBritishInvestment Banker47503900001
    COGGINS, Paul Marcus
    Tysoe Road
    CV35 0BN Lower Tysoe
    Willow House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tysoe Road
    CV35 0BN Lower Tysoe
    Willow House
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director Sales191791720002
    CREMER, Klaus
    Hoch Str 30
    59846 Sundern
    FOREIGN Germany
    Amministratore
    Hoch Str 30
    59846 Sundern
    FOREIGN Germany
    GermanDirector42058350001
    CROSSLEY, Peter Graham
    62 Church Hill
    IG10 1LB Loughton
    Essex
    Amministratore
    62 Church Hill
    IG10 1LB Loughton
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant51437100001
    HUTH, Johannes Peter
    90 Hamilton Terrace
    NW8 9UL London
    Amministratore
    90 Hamilton Terrace
    NW8 9UL London
    GermanCompany Director84684210001
    HUTH, Johannes Peter
    26 Perrymead Street
    SW6 3SP London
    Amministratore
    26 Perrymead Street
    SW6 3SP London
    GermanInvestment Banker35006520001
    KESSLER, Lawrence Bert
    5a 61 Cadogan Square
    SW1X 0HZ London
    Amministratore
    5a 61 Cadogan Square
    SW1X 0HZ London
    AmericanLawyer30743810002
    KLEINITZER, Peter Georg
    Ardetzenbergstrasse 27
    Feldkirch
    A-6800
    Austria
    Amministratore
    Ardetzenbergstrasse 27
    Feldkirch
    A-6800
    Austria
    AustrianCompany Director38718970004
    KOPRIO, Juergen Alfred
    Pfandbrunnen 192
    Mauren Fl 9493
    Liechtenstein
    Amministratore
    Pfandbrunnen 192
    Mauren Fl 9493
    Liechtenstein
    SwissChief Operating Officer73647520002
    LAYBOURN, David Anthony
    8 Swan Lane
    CM4 9BQ Stock
    Essex
    Amministratore
    8 Swan Lane
    CM4 9BQ Stock
    Essex
    UkBritishGroup Chief Executive81878040001
    MAST, Peter Karl Julius
    Unter Der Haar 5
    D-4773 Mohnesee - Gunne
    Germany
    Amministratore
    Unter Der Haar 5
    D-4773 Mohnesee - Gunne
    Germany
    GermanCompany Director30042640001
    MILLER, James Christopher
    27 Fife Road
    East Sheen
    SW14 7EJ London
    Amministratore
    27 Fife Road
    East Sheen
    SW14 7EJ London
    United KingdomBritishCompany Director1569600003
    REDIN, Lars Gustaf
    Norrskensbacken 17
    613656 Spanga
    FOREIGN Sweden
    Amministratore
    Norrskensbacken 17
    613656 Spanga
    FOREIGN Sweden
    SwedishCompany Director29340110002
    RHODES, Phillip Baverstock
    12 Peterborough Villas
    SW6 2AT London
    Amministratore
    12 Peterborough Villas
    SW6 2AT London
    United KingdomBritishChartered Accountant103078920001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector39155140002
    ROPER, David Alexander
    Widbrook House
    SL6 9RD Cookham
    Berkshire
    Amministratore
    Widbrook House
    SL6 9RD Cookham
    Berkshire
    BritishCompany Director18379560003
    RUSSELL, Mark Leonard James
    Chadelworth Way
    Kingston Bagpuize
    OX13 5FT Abingdon
    7
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Chadelworth Way
    Kingston Bagpuize
    OX13 5FT Abingdon
    7
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritishGeneral Manager247166640001
    SCOTT, George Rupert Hird
    16 Fulham Park Gardens
    SW6 4JX London
    Amministratore
    16 Fulham Park Gardens
    SW6 4JX London
    BritishTrainee Sol50417000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THORN LIGHTING INTERNATIONAL?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    England
    06 apr 2016
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    England
    No
    Forma giuridicaUnlimited With Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2815212
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    England
    06 apr 2016
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione680313
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    THORN LIGHTING INTERNATIONAL ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Third guarantee and debenture
    Creato il 03 mar 1999
    Consegnato il 09 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company under or pursuant to the senior finance documents (as defined) to the chargee (as security trustee for the beneficiaries (as defined)) and to each bank under or pursuant to the foreign exchange facilities (as defined)and all monies and liabilities due or to become due from any other company under or pursuant to the senior finance documents (as defined)to the chargee (as security trustee for each beneficiary (as defined)) and to each bank under or pursuant to the foreign exchange facilities (as defined)
    Brevi particolari
    L/H property screen 2 silverscreens elstree way borehamwood herts, l/h unit 8 the towers wilmslow road didsbury manchester, l/h 3 king george close eastern avenue west romford essex t/nos: HD265352 GM589037 EGL248447 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited
    Transazioni
    • 09 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second guarantee and debenture
    Creato il 13 gen 1999
    Consegnato il 21 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the senior finance documents and the foreign exchange facilities (both as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited,as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 21 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from each of the group obligors (as defined therein) to any of the secured parties (as defined therein) under the terms of the credit agreement, the other financing documents and subject to the terms of the intercreditor deed (as defined) for securing all moneys due or to become due from each of the group obligors (as defined therein) to thorn emi PLC as trustee for the seller note creditors (as defined) under the junior credit agreements (as defined) and/or this deed
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to (I) all the issued and outstanding shares in ab grundstenen 65912 to be renamed thorn jarnkonst ab (ii) the shares to be issued by thorn jarnkonst holding ab in a contemplated new issue in the amount of sek (iii) dividends as well as all other proceeds of and distributions in respect of any of the foregoing (collectively the "collateral") and (iv) any money or securities received by the pledgor in exchange or substitution for any of the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement for pledging shares (second ranking)
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment of bills of exchange and interest in the amount of £15,000,000 for thorn lighting group limited and certain companies within its group pursuant to a first demand guarantee dated 31/8/93
    Brevi particolari
    2,494 regsitered shares having a nominal value of 100FF in jules groupe S.A., registered at the companies registry of paris with number B391673357 (the shares) together with any income and allied income and rights deriving from the pledged shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thorn Emi PLC as Agent and Trustee for Itself and the Seller Note Creditors (As Defined)
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement for pledging of shares
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Obligations pursuant to bank credit facilities in the amount of £100,000,000 to thorn lighting group limited and certain companies within its group pursuant to a credit agreement dated 7/8/93
    Brevi particolari
    2,494 registered shares having a nominal value of 100FF in jules groupe S.A. registered at the companies registry of paris with number B391673357 (the shares) together with any income and allied income and all rights deriving from the pledged shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of mortgage of securities
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the obligations and liabilities of the company to the mortgagee as agent and trustee for itself and the secured parties; arising under a guarantee made by acn 060 142 501 pty limited and the company to the mortgagee dated 31/8/93
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company in all entitlements, dividends, proceeds, rights and other benefits payable accruing or arising in respect of (a) 11,000,000 ordinary a$1 shares in acn 060142501 pty. Limited and (b) any security other than (a) above in acn 060142501 pty. Limited that is registered in the name of or held by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (The Mortgagee)as Agent and Trustee for Itself and the Securedparties
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 16 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the group obligors (as defined therein) to any of the secured parties (as defined therein) under the terms of the credit agreement, the other financing documents and subject to the terms of the intercreditor deed (as defined) for securing all moneys due or to become due from each of the group obligors (as defined therein) to thorn emi PLC as trustee for the seller note creditors (as defined) under the junior credit agreements (as defined) and/or this deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (The Security Trustee) as Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transazioni
    • 16 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of mortgage
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 14 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and this charge
    Brevi particolari
    All the present and future right,title and interest of the mortgagor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thorn Emi PLC
    Transazioni
    • 14 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0