C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED

C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàC W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02820116
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OPENROW LIMITED20 mag 199320 mag 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Anna Holland come segretario

    2 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 19 mar 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del segretario cambiati per John Raymond Garwood il 23 ott 2009

    3 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    11 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 quoted 07/11/2008
    RES13

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio redatto al 30 giu 2004

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GARWOOD, John Raymond
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Segretario
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    British6767890001
    ANDERSON II, A Peter
    One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Amministratore
    One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    American46038780006
    IACOBESCU, George, Sir
    Flat 1
    4 Upper Brook Street
    W1K 6PA London
    Amministratore
    Flat 1
    4 Upper Brook Street
    W1K 6PA London
    United KingdomBritish42819220002
    LYONS, Russell James John
    12 Shouldham Street
    W1H 5FH London
    Amministratore
    12 Shouldham Street
    W1H 5FH London
    EnglandBritish81468120002
    HOLLAND, Anna Marie
    137 Cavendish Drive
    Leytonstone
    E11 1DJ London
    Segretario
    137 Cavendish Drive
    Leytonstone
    E11 1DJ London
    British99781150001
    HOSKING, Cherry Lyn
    7 Church Lane
    Deanshanger
    MK19 6HF Milton Keynes
    Northamptonshire
    Segretario
    7 Church Lane
    Deanshanger
    MK19 6HF Milton Keynes
    Northamptonshire
    British127691670001
    POTTER, Martin
    Rievaulx 42 Queensberry Avenue
    Copford
    CO6 1YN Colchester
    Essex
    Segretario
    Rievaulx 42 Queensberry Avenue
    Copford
    CO6 1YN Colchester
    Essex
    British31717200001
    PRECIOUS, Martin David
    Bowlers Green House
    SG9 9DE Bowlers Mead
    Hertfordshire
    Segretario
    Bowlers Green House
    SG9 9DE Bowlers Mead
    Hertfordshire
    British104849260001
    STALLARD, Paul
    25 Belmont Close
    UB8 1RF Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    25 Belmont Close
    UB8 1RF Uxbridge
    Middlesex
    British35180020001
    TEMPLE, Mark Howard
    Flat 1
    6 Byrne Road
    SW12 9HY London
    Segretario
    Flat 1
    6 Byrne Road
    SW12 9HY London
    British36956450001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BLOOM, Alan Robert
    7 Florida Close
    WD2 1ET Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Florida Close
    WD2 1ET Bushey Heath
    Hertfordshire
    British45267070001
    GARNER, Patrick Francis
    The Old Quarry
    Foxburrow Hill Road Bramley
    GU5 0BU Guildford
    Surrey
    Amministratore
    The Old Quarry
    Foxburrow Hill Road Bramley
    GU5 0BU Guildford
    Surrey
    EnglandBritish157714260001
    IACOBESCU, George, Sir
    Flat 35
    35-37 Grosvenor Square
    W1 London
    Amministratore
    Flat 35
    35-37 Grosvenor Square
    W1 London
    United KingdomBritish42819220002
    LEVENE, Peter Keith, Lord
    55 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    Amministratore
    55 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    EnglandBritish53666770001
    ROTHMAN, Gerald
    11 Carlton Hill
    NW8 0JX London
    Amministratore
    11 Carlton Hill
    NW8 0JX London
    UkBritish36855470001
    ROTHMAN, Gerald
    11 Besant House
    Boundary Road
    NW8 0HX London
    Amministratore
    11 Besant House
    Boundary Road
    NW8 0HX London
    British36855470002
    TEMPLE, Mark Howard
    Flat 1
    6 Byrne Road
    SW12 9HY London
    Amministratore
    Flat 1
    6 Byrne Road
    SW12 9HY London
    British36956450001
    WALSOM, Roger Benham
    Brackens Forest Road
    East Horsley
    KT24 5BA Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Brackens Forest Road
    East Horsley
    KT24 5BA Leatherhead
    Surrey
    British44808960001
    YOUNG, Charles Bellamy
    Flat B 58 Eaton Square
    SW1W 9BG London
    Amministratore
    Flat B 58 Eaton Square
    SW1W 9BG London
    American35137740002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    C W INVESTMENTS (PHASE I) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 05 set 1996
    Consegnato il 19 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    And varying the terms of the "core debenture" dated 27TH december 1995
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets (other than thee excluded assets) all as defined in form 395 relative to this charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trustee Company Limited(As Security Agent)
    Transazioni
    • 19 set 1996Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 dic 1995
    Consegnato il 16 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities and obligations due or to become due from any member of of the obligor group to the chargees pursuant to the terms of the facility agreement and/or any other finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Legal mortgage any real property now belonging to the company and the proceeds of sale therof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trustee Company Limited (As Security Agent)
    Transazioni
    • 16 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second fixed and floating charge debenture
    Creato il 27 dic 1995
    Consegnato il 09 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee in any manner whatsoever under or in connection with any finance document (as defined)
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage,all real property in england and wales including that described in schedule 2 of the debenture,but excluding the lul real property see ch microfiche for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • European Investment Bank
    Transazioni
    • 09 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 ott 1993
    Consegnato il 11 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the lifo liabilities,consruction loan liabilities,residual dlr liabilities counter indemnity liabilities and all monies liabilities
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 11 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 giu 1993
    Consegnato il 24 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and each obligor to the chargee under the terms of the financing documents to which such obligor is party
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0