PROJECT CEYLON LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PROJECT CEYLON LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02820389 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PROJECT CEYLON LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PROJECT CEYLON LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Building 8 Croxley Green Business Park Hatters Lane WD18 8PX Watford Herts |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PROJECT CEYLON LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CINESITE (EUROPE) LIMITED | 03 ago 1993 | 03 ago 1993 |
| LAUNCHDASH SERVICES LIMITED | 21 mag 1993 | 21 mag 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PROJECT CEYLON LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PROJECT CEYLON LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per PROJECT CEYLON LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomina di Mr Nicholas Paul Goater come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Derek Lambert come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Hemelone, Boundary Way Hemel Hempstead Herts HP2 7YU* in data 21 mag 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Webb come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Duncan Rodger come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Courtney Vanderslice come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Duncan Rodger come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Antony Hunt come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Courtney Vanderslice come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Antony Hunt come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Duncan Rodger come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Duncan Rodger come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Derek Alan Lambert come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Sandra Kathryn Pym come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr David George Webb come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PROJECT CEYLON LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYM, Sandra Kathryn | Segretario | Croxley Green Business Park Hatters Lane WD18 8PX Watford Building 8 Herts England | 169323590001 | |||||||
| GOATER, Nicholas Paul | Amministratore | Croxley Green Business Park Hatters Lane WD18 8PX Watford Building 8 Hertforshire Uk | Uk | British | 11713770002 | |||||
| BARNETT, Neil James | Segretario | Wisteria Cottage Onslow Crescent GU22 7AU Woking Surrey | British | 73925280002 | ||||||
| GIBSON, Helen Victoria | Segretario | Eton Avenue NW3 3ET London 59 | British | 109248280001 | ||||||
| IRWIN, Noreen Mary | Segretario | 41 Woodhouse Road North Finchley N12 9ET London | British | 48356190001 | ||||||
| PEZZACK, Susan Dawn | Segretario | 104 Sidney Road KT12 3SA Walton On Thames Surrey | British | 45811930002 | ||||||
| RODGER, Duncan Alexander | Segretario | Orchard Avenue KT3 4JU New Malden 25 Surrey England | British | 114518450002 | ||||||
| ROGERS, Helen Susan Fletcher | Segretario | Conway House 5 Furlong Lane Totternhoe LU6 1QR Dunstable Bedfordshire | British | 4869830001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BALL, Geoffrey Ronald | Amministratore | Glebe Farm Northcroft Weedon HP22 4NR Aylesbury Buckinghamshire | British | 3979110003 | ||||||
| BARNETT, Neil James | Amministratore | Wisteria Cottage Onslow Crescent GU22 7AU Woking Surrey | United Kingdom | British | 73925280002 | |||||
| BROWN, Colin | Amministratore | 27 Ennismore Avenue W12 9RJ London | United Kingdom | British | 34528720001 | |||||
| DECOUX, Bertrand | Amministratore | 10 La Cie Des Champs 01280 Prevessin-Moens France | French | 89164920002 | ||||||
| FOLEY, Aidan Patrick | Amministratore | 6178 Grey Rock Road Agoura Hills 91301 California Usa | American | 44158900001 | ||||||
| FRANKLIN, Warren | Amministratore | 164 Linden Lane 94941 Mill Valley California Usa | American | 49357970001 | ||||||
| GIBSON, Helen Victoria | Amministratore | Eton Avenue NW3 3ET London 59 | England | British | 109248280001 | |||||
| GRANELL, Jose Francisco | Amministratore | Monks Lantern Ruxbury Road KT16 9NH Chertsey Surrey | England | British | 116022810001 | |||||
| HUNT, Antony | Amministratore | Georgian Heights Blind Lane SL8 5NJ Bourne End Richmond House Bucks England | England | British | 88908710002 | |||||
| HUNT, Cleo Bradley | Amministratore | 5 Grove Way KT10 8HH Esher Surrey | Us Citizen | 48452040001 | ||||||
| HUNT, Cleo Bradley | Amministratore | 1133 N Hollywood Way 91505 Burbank California Usa | Usa | 48452040002 | ||||||
| JONES, Edward Lemmon | Amministratore | 1321 Riverside Drive 91506 Burbank California Usa | Us Citizen | 35967680001 | ||||||
| KERCHER, Brian Thomas | Amministratore | Burrowood 5 Stopps Orchard HP27 9JB Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 74045570001 | |||||
| LAMBERT, Derek Alan | Amministratore | Croxley Green Business Park Hatters Lane WD18 8PX Watford Building 8 Herts England | England | British | 112654890001 | |||||
| MAYSON, Robert Jeffries | Amministratore | Church View Lukes Lea Marsworth HP23 4NH Tring Herts | England | British | 114392490001 | |||||
| MCKIBBIN, Robert Gregory | Amministratore | Hawks Nest Manor Road, Penn HP10 8HY High Wycombe Buckinghamshire | Australian | 67101750001 | ||||||
| PECK, William Walfred | Amministratore | 198 Fishers Road 14534 Pittsford New York Usa | Us Citizen | 35967700001 | ||||||
| RODGER, Duncan Alexander | Amministratore | Orchard Avenue KT3 4JU New Malden 25 Surrey England | England | British | 114518450002 | |||||
| ROGERS, Helen Susan Fletcher | Amministratore | Conway House 5 Furlong Lane Totternhoe LU6 1QR Dunstable Bedfordshire | British | 4869830001 | ||||||
| STENSLIE, Bjorn | Amministratore | 23179 Park Pinta Calabasas Ca 91302 Usa | Norwegian | 77288950002 | ||||||
| VANDERSLICE, Courtney Anne | Amministratore | 5 Corney Reach Way W4 2TY London | England | American | 72013830001 | |||||
| WEBB, David George | Amministratore | Hemelone, Boundary Way Hemel Hempstead HP2 7YU Herts | England | British | 140693260001 | |||||
| WELLS, Christopher David | Amministratore | High Raise Burgess Wood Road HP9 1EQ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 50303950001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
PROJECT CEYLON LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 30 gen 2007 Consegnato il 01 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 15 july 1991 | Creato il 25 lug 2005 Consegnato il 10 ago 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0