CLEARWATER HOMES LIMITED

CLEARWATER HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLEARWATER HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02823494
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLEARWATER HOMES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CLEARWATER HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3-4 Baird Road
    EN1 1SJ Enfield
    Middlesex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLEARWATER HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per CLEARWATER HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2023

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 12E Manor Road London N16 5SA a 3-4 Baird Road Enfield Middlesex EN1 1SJ in data 29 nov 2023

    1 pagineAD01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2022

    3 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 29 giu 2022 al 30 giu 2022

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 apr 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 29 giu 2021

    3 pagineAA

    Bilancio di micro-entità redatto al 29 giu 2020

    3 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2020 al 29 giu 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2019

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2018

    2 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Mr Edward John Schwartz come persona con controllo significativo il 24 apr 2018

    2 paginePSC04

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2017

    2 pagineAA

    Bilancio modificato di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015

    6 pagineAAMD

    Bilancio modificato di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2016

    6 pagineAAMD

    Iscrizione dell'ipoteca 028234940012, creata il 25 lug 2017

    19 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 028234940013, creata il 25 lug 2017

    13 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di CLEARWATER HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCHWARTZ, Brenda Joyce
    3 Laburnum Close
    Sheering
    CM22 7LD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Laburnum Close
    Sheering
    CM22 7LD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British104565840001
    SCHWARTZ, Edward John
    3 Laburnum Close
    The Street
    CM22 7LD Sheering
    Amministratore
    3 Laburnum Close
    The Street
    CM22 7LD Sheering
    United KingdomBritishCompany Director82087810001
    TOWNSHEND, Jean Ann
    107 North End House
    W14 0RY London
    Segretario
    107 North End House
    W14 0RY London
    BritishCo Director/Secretary8017160001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    SCHWARTZ, Steven James Edward
    3 Laburnum Close
    The Street
    CM22 7LD Sheering
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Laburnum Close
    The Street
    CM22 7LD Sheering
    Hertfordshire
    BritishTransport Manager107752050001
    TOWNSHEND, Donald William
    107 North End House
    Fitzjames Avenue
    W14 0RY London
    Amministratore
    107 North End House
    Fitzjames Avenue
    W14 0RY London
    United KingdomBritishCo Director55994250001
    TOWNSHEND, Jean Ann
    107 North End House
    W14 0RY London
    Amministratore
    107 North End House
    W14 0RY London
    United KingdomBritishCo Director/Secretary8017160001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CLEARWATER HOMES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Edward John Schwartz
    Laburnum Close
    Sheering
    CM22 7LD Bishop's Stortford
    3
    England
    06 apr 2016
    Laburnum Close
    Sheering
    CM22 7LD Bishop's Stortford
    3
    England
    No
    Nazionalità: English
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CLEARWATER HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 lug 2017
    Consegnato il 01 ago 2017
    In corso
    Breve descrizione
    1 by way of legal mortgage all freehold and leasehold property now vested in the company together with all buildings, fixtures and fixed plant and machinery from time to time on that property.. 2 by way of fixed charge all estates or interests in any freehold and leasehold property of the company (not being property charged by 1 above) now and in the future vested in the company together with all buildings, fixtures and fixed plant and machinery from time to time on that property.. 3 by way of fixed charge all intellectual property rights choses in action and claims now and in the future belonging to the company.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Commercial Acceptances Limited
    Transazioni
    • 01 ago 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 25 lug 2017
    Consegnato il 01 ago 2017
    In corso
    Breve descrizione
    All that freehold property situate and known as barrington hall bungalow dunmow road hatfield broad oak bishop's stortford CM22 7JL registered at hm land registry with title absolute under title number EX938050.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Commercial Acceptances Limited
    Transazioni
    • 01 ago 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 set 2016
    Consegnato il 07 ott 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Barringto hall bungalow dunmow road hatfield broad oak bishop's stortford hertfordshire.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 12 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining the tollgate public house whalebone lane north chadwell heath essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 12 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land adjoining the tollgate public house whalebone lane north chadwell heath.
    Persone aventi diritto
    • D a Moody (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 12 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 12 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land adjoining the tollgate public house whalebone lane north chadwell heath and all the undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever present or future.
    Persone aventi diritto
    • D a Moody (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 12 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 21 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 02 dic 1996
    Consegnato il 06 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Granville Bank Limited
    Transazioni
    • 06 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1996
    Consegnato il 06 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as plots 8 and 9 jolly brows stich mi-lane,harwood,bolton; t/no gm 689336 with all rents,rights,interests under any contracts or agreements; the proceeds of sale thereof; all buildings,fixtures,fittings,plant and machinery thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Granville Bank Limited
    Transazioni
    • 06 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 31 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Granville Trust Limited
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the south west side of marsh lane mill hill t/n NGL711079 first fixed legal charge all its right to and interest in any proceeds of sale of the whole or any part of the mortgage property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Granville Trust Limited
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings on the south side of allendale road greenford t/n NGL712636 first fixed legal charge all its right to and interest in any proceeds of sale of the whole or any part of the mortgage property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Granville Trust Limited
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 30 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Granville Trust Limited
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0