ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02825291 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Meridian Trinity Square 23-59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Middlesex |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 set 2012
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alicia Essex come segretario in data 07 set 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alicia Essex come amministratore in data 07 set 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ann French il 01 ago 2012 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Magdalena Koncikova come amministratore in data 20 set 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Alicia Essex come amministratore in data 20 set 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Hall Mcgibbon come amministratore in data 20 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Darren Mark Millard come amministratore in data 20 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Michael Jenkins come amministratore in data 20 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hugh Alan Taylor Fitzpatrick come amministratore in data 20 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Ann French come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Toby Ford come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alicia Essex il 01 gen 2010 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alicia Essex il 20 lug 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per John Michael Jenkins il 01 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENCH, Ann | Segretario | Meridian Trinity Square 23-59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Middlesex | 161409120001 | |||||||
| KONCIKOVA, Magdalena | Amministratore | 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Trinity Square Middlesex United Kingdom | United Kingdom | Slovakian | 163324190001 | |||||
| ESSEX, Alicia | Segretario | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex | British | 55569560002 | ||||||
| GREGORY, Janet Ailsa | Segretario | Eastwood Lodge Whitfield GL12 8EA Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 54836580002 | ||||||
| LAWRENCE, William Sackville Gwynne | Segretario | 7 Byam Street SW6 2RB London | British | 32571030001 | ||||||
| RYAN, Gerard Jude | Segretario | 47 Kingsmead Road Tulse Hill SW2 3HY London | Irish | 32962580001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BABER, Jeremy David | Amministratore | 94 Candwr Park Ponthir NP18 1HN Newport Gwent | British | 109606970001 | ||||||
| BARRATT, Simon James Knevett | Amministratore | 33 Stadium Street SW10 0PU London | British | 25864760002 | ||||||
| BRAMHALL, John Robert | Amministratore | 11 Stoke Hill Stoke Bishop BS9 1JL Bristol | British | 1020270002 | ||||||
| DHALIWAL, Harminder | Amministratore | 5 Watson Close RG40 4YF Wokingham Berkshire | British | 80423030001 | ||||||
| ELLIS, Christopher | Amministratore | 12 Lattimer Place Chiswick W4 2UA London | British | 52013970001 | ||||||
| ESSEX, Alicia | Amministratore | 23-59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Trinity Square Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 155696080001 | |||||
| FIELDEN, David Shaw | Amministratore | Kingsfield Old Midford Road BA2 7DH Bath | England | British | 8502310001 | |||||
| FITZPATRICK, Hugh Alan Taylor | Amministratore | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | United Kingdom | British | 139406230001 | |||||
| FORD, Toby Duncan | Amministratore | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | United Kingdom | British | 148654320001 | |||||
| GANE, Peter Anthony | Amministratore | Herb Cottage 5 Red Pitt Dilton Marsh BA13 4BJ Westbury Wiltshire | British | 81248280001 | ||||||
| GIRARD, Sylvain Andre | Amministratore | 9 Redcliffe Gardens 66 Grove Park Road W4 London | England | Canadian | 85777970002 | |||||
| GREEN, Richard William | Amministratore | Richborough House Sandy Lane Sunningdale SL5 0ND Ascot Berkshire | British | 121346530001 | ||||||
| GREEN, Robert | Amministratore | Tavistock Christ Church Road GU25 4PT Virginia Water Surrey | American | 79378980001 | ||||||
| GREGORY, Janet Ailsa | Amministratore | Eastwood Lodge Whitfield GL12 8EA Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 54836580002 | ||||||
| HUNTER GORDON, Christopher Neil | Amministratore | 31 Alexander Street W2 5NV London | British | 1802880001 | ||||||
| HURST, Martin Peter | Amministratore | 18 The Lawns Gotherington GL52 9QT Cheltenham Gloucestershire | British | 116377130001 | ||||||
| HURST, Tiffany | Amministratore | Flat 6 24 Collingham Gardens SW5 0HN London | American | 94387970002 | ||||||
| IVERSEN, Arnold | Amministratore | Hamilton House Blackwell Hall L Ane Leyhill HP5 1UN Chesham Buckinghamshire | British | 90729600001 | ||||||
| JENKINS, John Michael | Amministratore | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | England | British | 115008010001 | |||||
| JURRIES, Donald Lewis | Amministratore | 12 Russell Close Regency Quay Chiswick W4 2NU London | American | 71266350001 | ||||||
| LAWRENCE, William Sackville Gwynne | Amministratore | 7 Byam Street SW6 2RB London | United Kingdom | British | 32571030001 | |||||
| LEESMITH, Alan Eustace | Amministratore | Bavelaw Copyhold Lane Cuckfield RH17 5EB Haywards Heath West Sussex | England | British | 5265930001 | |||||
| LOMAS, Paul John | Amministratore | 12 Burwardsley Way Kingsmead CW9 8WN Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 127596100001 | |||||
| MCCLELLAND, Lynn Fiona | Amministratore | 85 St George Place Deanery Road BS1 5QH Bristol | British | 108053630001 | ||||||
| MCGIBBON, William Hall | Amministratore | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | United Kingdom | British | 131612680004 | |||||
| MCNAMARA, Mary Jane | Amministratore | 96 Lake Rise RM1 4EE Gidea Park Essex | British | 69295880001 | ||||||
| MILLARD, Darren Mark | Amministratore | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex | United Kingdom | British | 148916890001 | |||||
| MORRIS, Gavin Peter | Amministratore | 93 Reedley Road Westbury On Trym BS9 3TB Bristol | United Kingdom | British | 209898490001 |
ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed dated 31ST march 1995 | Creato il 31 mar 1995 Consegnato il 07 apr 1995 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured creditors ( as defined in the deed suplemental to the terms of the deed dated 15TH february 1994 and/or this deed | |
Brevi particolari All the company's beneficial right title and interest present and future in ,to and under the receivables trust deed , andthe receivables trust in and to the receivables trust property and in and to all moneys ,right powers , and property whatsoever which may from time to time be distributed or derived from , or accrue on or relate to the receivables trust, .please see doc for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 30 dic 1994 Consegnato il 11 gen 1995 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of charge dated 16TH september 1993 | |
Brevi particolari All right, title, interest and benefit in the receivables trust deed and the receivables trust. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 30 set 1994 Consegnato il 08 ott 1994 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of charge dated 15TH february 1994 | |
Brevi particolari All its beneficial right, title interest and benefit present and future in, to and under the receivables trust deed and the receivables trust. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 30 giu 1994 Consegnato il 01 lug 1994 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of charge dated 15 february 1994 | |
Brevi particolari All right title interest and benefit under the receivables trust deed and receivables trust and the maintenance trust and head lease agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 31 mar 1994 Consegnato il 15 apr 1994 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of charge dated 15 february 1994 | |
Brevi particolari All right title and interest and benefit under the receivables trust deed and receivables trust, the maintenance trust deed and the maintenance trust and the head lease agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 16 feb 1994 Consegnato il 02 mar 1994 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under and pursuant to the trust deed, the other transaction documents, the conditions, the notes, the coupons and the deed of charge | |
Brevi particolari All right title and interest in the receivables trust deed the maintenance trust deed and head lease agreements. Floating charge over all undertaking property and assets including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 15 feb 1994 Consegnato il 02 mar 1994 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under and pursuant to the trust deed, the other transaction documents, the conditions, the notes, the coupons and the deed of charge | |
Brevi particolari All right title and interest in the receivables trust deed the maintenance trust deed and the head lease agreements. Floating charge over all undertaking property and assets including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0