BON BON BUDDIES LIMITED

BON BON BUDDIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBON BON BUDDIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02827349
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BON BON BUDDIES LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di zucchero e cioccolato e di confetteria di zucchero (46360) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova BON BON BUDDIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Old Exchange 234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BON BON BUDDIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PACKATEERS LIMITED15 giu 199315 giu 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di BON BON BUDDIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per BON BON BUDDIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineLIQ14

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    28 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 nov 2021

    20 pagineLIQ03

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 30 nov 2020

    LRESEX

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    11 pagineCVA4

    Indirizzo della sede legale modificato da Suite 5a 5a Quest House, St Mellons Business Park Cardiff CF3 0EY United Kingdom a The Old Exchange 234 Southchurch Road Southend-on-Sea Essex SS1 2EG in data 14 dic 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 apr 2019

    24 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 29 apr 2019 al 28 apr 2019

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2019 al 29 apr 2019

    1 pagineAA01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 14 ott 2019

    10 pagineCVA3

    Bilancio redatto al 30 apr 2018

    31 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 10

    6 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    5 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da One Foxes Lane Oakdale Business Park Blackwood South Wales NP12 4AB a Suite 5a 5a Quest House, St Mellons Business Park Cardiff CF3 0EY in data 31 gen 2019

    1 pagineAD01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    5 pagineCVA1

    Cessazione della carica di Justin Paul Thomas come amministratore in data 13 set 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joanne Yvonne Manfield come amministratore in data 19 lug 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BON BON BUDDIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOWARTH, Christopher Stuart
    Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange 234
    Essex
    Amministratore
    Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange 234
    Essex
    MaltaBritish34972700005
    CARR, Timothy James
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Segretario
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    British195790700001
    DAVIES, Geoffrey Clive
    81 Lake Road West
    Roath Park
    CF23 5PH Cardiff
    Segretario
    81 Lake Road West
    Roath Park
    CF23 5PH Cardiff
    British30472530002
    HOWARTH, Christopher Stuart
    Pont Gaer
    Tretower
    NP8 1SB Crickhowell
    Powys
    Segretario
    Pont Gaer
    Tretower
    NP8 1SB Crickhowell
    Powys
    British34972700001
    KNOWLES, Mark Henry
    3 Rhuddlan Close
    NP10 8QU Newport
    Gwent
    Segretario
    3 Rhuddlan Close
    NP10 8QU Newport
    Gwent
    British80799750001
    ZAMMIT, Ronald Charles
    Dartington Drive
    Pontprennau
    CF23 8SA Cardiff
    28
    South Glamorgan
    United Kingdom
    Segretario
    Dartington Drive
    Pontprennau
    CF23 8SA Cardiff
    28
    South Glamorgan
    United Kingdom
    British134812430001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    CARR, Timothy James
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Amministratore
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    United KingdomBritish195790700001
    CAWDELL, Duncan
    4 Silure Way
    Langstone
    NP18 2NU Newport
    Gwent
    Amministratore
    4 Silure Way
    Langstone
    NP18 2NU Newport
    Gwent
    British98220360001
    DAVIES, Peter Donald
    42 Elm Road
    East Sheen
    SW14 7JQ London
    Amministratore
    42 Elm Road
    East Sheen
    SW14 7JQ London
    British46493680001
    DYER, Graham Paul
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Amministratore
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    United KingdomBritish125487800001
    HOWARTH, Albert Thomas
    18 Kooringa
    CR6 9JP Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    18 Kooringa
    CR6 9JP Warlingham
    Surrey
    British36989900001
    HOWARTH, Pauline June
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Amministratore
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    United KingdomBritish43796710001
    KNOWLES, Mark Henry
    3 Rhuddlan Close
    NP10 8QU Newport
    Gwent
    Amministratore
    3 Rhuddlan Close
    NP10 8QU Newport
    Gwent
    British80799750001
    KURSAR, Ivan
    3 St Anns Place
    BA1 2BJ Bath
    Avon
    Amministratore
    3 St Anns Place
    BA1 2BJ Bath
    Avon
    British29533070001
    MANFIELD, Joanne Yvonne
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Amministratore
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    WalesBritish198672640001
    MILES, Stephen Anthony
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Amministratore
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    WalesWelsh67332510001
    MONK, Paul John
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    British71562530002
    MONK, Paul John
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    British71562530002
    SUTHERLAND, Martin
    Red House
    Earlswood
    NP16 6AW Chepstow
    Gwent
    Amministratore
    Red House
    Earlswood
    NP16 6AW Chepstow
    Gwent
    UkBritish190607410001
    THOMAS, Justin Paul
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Amministratore
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    WalesBritish183392850001
    TILLEY, Barry Thomas William
    Pheasants Seymour Plain
    SL7 3DA Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pheasants Seymour Plain
    SL7 3DA Marlow
    Buckinghamshire
    British45959380001
    TOMS, Kevin Paul
    Midsummer
    19 Delamare Way
    OX2 9HZ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Midsummer
    19 Delamare Way
    OX2 9HZ Oxford
    Oxfordshire
    British67332780001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BON BON BUDDIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Christopher Stuart Howarth
    Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange 234
    Essex
    06 apr 2016
    Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange 234
    Essex
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Malta
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BON BON BUDDIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Creato il 07 ott 2011
    Consegnato il 11 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 11 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 lug 2011
    Consegnato il 04 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 mar 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 16 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge of deposit
    Creato il 24 nov 2004
    Consegnato il 30 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 22120568 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 dic 2003
    Consegnato il 06 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 24 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 24 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 28 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Brevi particolari
    The shares together with all dividends and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 28 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 28 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Brevi particolari
    The shares together with all dividends or other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 28 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 28 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 28 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 31 ago 1999
    Consegnato il 14 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • G E Capital Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 14 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over book debts
    Creato il 11 lug 1994
    Consegnato il 16 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or in connection with a financing agreement (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 16 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 06 dic 1993
    Consegnato il 14 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BON BON BUDDIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 ott 2018Data della riunione per approvare il CVA
    14 dic 2020Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Eric Walls
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    Praticante
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    2
    DataTipo
    30 nov 2020Inizio della liquidazione
    20 apr 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Louise Donna Baxter
    Begbies Traynor (Central) Llp The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Lloyd Christopher Biscoe
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex
    Praticante
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex
    Dominik Thiel-Czerwinke
    The Old Exchange 234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Praticante
    The Old Exchange 234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0