ACCOLADE EUROPE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ACCOLADE EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02830414 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ACCOLADE EUROPE LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ACCOLADE EUROPE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Thomas Hardy House 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Surrey |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ACCOLADE EUROPE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MATTHEW CLARK WHOLESALE BOND LIMITED | 01 mag 1997 | 01 mag 1997 |
| FREETRADERS (GRANTS OF ST JAMES'S) LIMITED | 20 ott 1993 | 20 ott 1993 |
| OVAL (888) LIMITED | 25 giu 1993 | 25 giu 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ACCOLADE EUROPE LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2017 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2018 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per ACCOLADE EUROPE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 028304140003, creata il 14 ott 2016 | 37 pagine | MR01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 028304140002, creata il 14 ott 2016 | 68 pagine | MR01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Graham Wood il 02 ott 2015 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy Alexander Stevenson il 02 ott 2015 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Michael Schaafsma il 02 ott 2015 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert John Ratcliffe il 02 ott 2015 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Lee Gorst il 02 ott 2015 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Jeremy Alexander Stevenson il 02 ott 2015 | 3 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Nicola Jane Spencer il 02 ott 2015 | 3 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Accolade House the Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR a Thomas Hardy House 2 Heath Road Weybridge Surrey KT13 8TB in data 25 ago 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Lee Gorst il 01 giu 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Anthony Graham Wood come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ACCOLADE EUROPE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER, Nicola Jane | Segretario | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 180939000001 | |||||||
| STEVENSON, Jeremy Alexander | Segretario | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 161850330001 | |||||||
| GORST, Steven Lee | Amministratore | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Canada | Canadian | 180938750002 | |||||
| RATCLIFFE, Robert John | Amministratore | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 185752460001 | |||||
| SCHAAFSMA, Paul Michael | Amministratore | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 105189170004 | |||||
| STEVENSON, Jeremy Alexander | Amministratore | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | 161846280001 | |||||
| WOOD, Anthony Graham | Amministratore | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | 185752470001 | |||||
| CLOTHIER, Esther | Segretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 162012580001 | |||||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Segretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||
| GREGORY, David Noel | Segretario | 15 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | British | 14735490001 | ||||||
| HUGHES, David John | Segretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 157467610002 | |||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Segretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | British | 69554640002 | ||||||
| OVALSEC LIMITED | Segretario nominato | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||
| AIKENS, Peter | Amministratore | Princes Lodge BA4 5HN Shepton Mallet Somerset | British | 2228040002 | ||||||
| BONES, David Christopher | Amministratore | 6 Trowle Common BA14 9BJ Trowbridge Wiltshire | England | British | 60302270001 | |||||
| BROCKETT, Gavin Stuart | Amministratore | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | South African | 167554030002 | |||||
| CHRISTENSEN, Troy | Amministratore | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | American | 130789730003 | |||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Amministratore | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | 28396500005 | |||||
| CRANE, Charles Michael | Amministratore | 41 Queens Gardens W2 3AA London | British | 14735480001 | ||||||
| CREIGHTON, Thomas Hugh | Amministratore | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | 157727790001 | |||||
| DICK, Thomas Gordon | Amministratore | Yew House Giffards Meadow GU9 8DA Farnham Surrey | British | 46246620001 | ||||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Amministratore | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||
| FISHER, David Michael | Amministratore | Ashley Wood Kingsdown SN14 9BH Corsham Wiltshire | British | 76571110001 | ||||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Amministratore | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | 137615160001 | |||||
| GREGORY, David Noel | Amministratore | 15 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | 14735490001 | |||||
| HODGES, Nigel Ian | Amministratore | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | 75692570001 | ||||||
| HOYLE, Russell Blackburn | Amministratore | 77 Richmond Park Road East Sheen SW14 8JY London | British | 52822380001 | ||||||
| HUGHES, David John | Amministratore | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | 157415150002 | |||||
| HUNTLEY, Peter William | Amministratore | 28 Allan Glen Gardens Bishopbriggs G64 3BG Glasgow | Scotland | British | 46387640002 | |||||
| KLEIN, David | Amministratore | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | 119928070001 | ||||||
| LOUSADA, James David | Amministratore | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | 152222000001 | |||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Amministratore | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | 69554640002 | |||||
| O'HALLERAN, James William | Amministratore | Barndale Abbotts Bromley Road DE13 8RA Hoar Cross Staffordshire | British | 103876820001 | ||||||
| PETERS, Richard David | Amministratore | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | 60630980002 | |||||
| RUGGERI, Andrea Aldo | Amministratore | Hermitage 4 Mendip Leigh West Harptree Road, East Harptree BS40 6BQ Bristol Avon | United Kingdom | British | 36468270002 |
ACCOLADE EUROPE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 14 ott 2016 Consegnato il 31 ott 2016 | In corso | ||
Breve descrizione Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the original transaction security. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 14 ott 2016 Consegnato il 21 ott 2016 | In corso | ||
Breve descrizione Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the deed. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 ott 2011 Consegnato il 25 ott 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0