ACCOLADE EUROPE LIMITED

ACCOLADE EUROPE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACCOLADE EUROPE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02830414
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Thomas Hardy House
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MATTHEW CLARK WHOLESALE BOND LIMITED01 mag 199701 mag 1997
    FREETRADERS (GRANTS OF ST JAMES'S) LIMITED20 ott 199320 ott 1993
    OVAL (888) LIMITED25 giu 199325 giu 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    5 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    12 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    4 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 028304140003, creata il 14 ott 2016

    37 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 028304140002, creata il 14 ott 2016

    68 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 set 2016

    Stato del capitale al 13 set 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 set 2016

    Stato del capitale al 12 set 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Graham Wood il 02 ott 2015

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy Alexander Stevenson il 02 ott 2015

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Michael Schaafsma il 02 ott 2015

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert John Ratcliffe il 02 ott 2015

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Lee Gorst il 02 ott 2015

    3 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Jeremy Alexander Stevenson il 02 ott 2015

    3 pagineCH03

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Nicola Jane Spencer il 02 ott 2015

    3 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da , Accolade House the Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR a Thomas Hardy House 2 Heath Road Weybridge Surrey KT13 8TB in data 25 ago 2016

    2 pagineAD01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Lee Gorst il 01 giu 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 giu 2014

    Stato del capitale al 09 giu 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Anthony Graham Wood come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPENCER, Nicola Jane
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    180939000001
    STEVENSON, Jeremy Alexander
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    161850330001
    GORST, Steven Lee
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    CanadaCanadian180938750002
    RATCLIFFE, Robert John
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish185752460001
    SCHAAFSMA, Paul Michael
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish105189170004
    STEVENSON, Jeremy Alexander
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralian161846280001
    WOOD, Anthony Graham
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralian185752470001
    CLOTHIER, Esther
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    162012580001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Segretario
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    British28396500005
    GREGORY, David Noel
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Segretario
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    British14735490001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    157467610002
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Segretario
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    British69554640002
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Segretario nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    AIKENS, Peter
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    Amministratore
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    British2228040002
    BONES, David Christopher
    6 Trowle Common
    BA14 9BJ Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    6 Trowle Common
    BA14 9BJ Trowbridge
    Wiltshire
    EnglandBritish60302270001
    BROCKETT, Gavin Stuart
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaSouth African167554030002
    CHRISTENSEN, Troy
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAmerican130789730003
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Amministratore
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritish28396500005
    CRANE, Charles Michael
    41 Queens Gardens
    W2 3AA London
    Amministratore
    41 Queens Gardens
    W2 3AA London
    British14735480001
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritish157727790001
    DICK, Thomas Gordon
    Yew House Giffards Meadow
    GU9 8DA Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Yew House Giffards Meadow
    GU9 8DA Farnham
    Surrey
    British46246620001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Amministratore
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritish1491130002
    FISHER, David Michael
    Ashley Wood
    Kingsdown
    SN14 9BH Corsham
    Wiltshire
    Amministratore
    Ashley Wood
    Kingsdown
    SN14 9BH Corsham
    Wiltshire
    British76571110001
    GLENNIE, Helen Margaret
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish137615160001
    GREGORY, David Noel
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Amministratore
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    EnglandBritish14735490001
    HODGES, Nigel Ian
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    Amministratore
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    British75692570001
    HOYLE, Russell Blackburn
    77 Richmond Park Road
    East Sheen
    SW14 8JY London
    Amministratore
    77 Richmond Park Road
    East Sheen
    SW14 8JY London
    British52822380001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralian157415150002
    HUNTLEY, Peter William
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    Amministratore
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    ScotlandBritish46387640002
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    American119928070001
    LOUSADA, James David
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish152222000001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish69554640002
    O'HALLERAN, James William
    Barndale
    Abbotts Bromley Road
    DE13 8RA Hoar Cross
    Staffordshire
    Amministratore
    Barndale
    Abbotts Bromley Road
    DE13 8RA Hoar Cross
    Staffordshire
    British103876820001
    PETERS, Richard David
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish60630980002
    RUGGERI, Andrea Aldo
    Hermitage 4 Mendip Leigh
    West Harptree Road, East Harptree
    BS40 6BQ Bristol
    Avon
    Amministratore
    Hermitage 4 Mendip Leigh
    West Harptree Road, East Harptree
    BS40 6BQ Bristol
    Avon
    United KingdomBritish36468270002

    ACCOLADE EUROPE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 ott 2016
    Consegnato il 31 ott 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the original transaction security.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as New UK Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 ott 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 14 ott 2016
    Consegnato il 21 ott 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the deed.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as UK Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 ott 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 18 ott 2011
    Consegnato il 25 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Distribution Finance Europe Limited (As UK Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0