BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02831648 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CLEARTEST LIMITED | 30 giu 1993 | 30 giu 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 nov 2017 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Notifica di Bl Retail Warehousing Holding Company Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2017 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 03 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 7 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 4 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 9 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 6 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Mark Webb come amministratore in data 10 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 10 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Andrew Roberts come amministratore in data 10 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Stuart Macey come amministratore in data 10 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Benjamin Toby Grose come amministratore in data 10 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lucinda Margaret Bell come amministratore in data 10 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Segretario | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | British | 32809000002 | ||||||||||
| PENRICE, Victoria Margaret | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | 190034210001 | |||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BERRY, David Charles | Amministratore | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 166550001 | ||||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 1898090001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| MACEY, Paul Stuart | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205652070001 | |||||||||
| MADDISON, John Roman Patrick | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 159016320001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Amministratore | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||||||
| PENRICE, Victoria Margaret | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 189931090001 | |||||||||
| RITBLAT, John, Sir | Amministratore | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | 41694870001 | |||||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Amministratore | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||||||
| ROBERTS, Graham Charles | Amministratore | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 63986410004 | |||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 148183670001 | |||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 148183670001 | |||||||||
| VANDEVIVERE, Jean-Marc | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | 170947050001 | |||||||||
| WEBB, Nigel Mark | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 58059360001 | |||||||||
| WESTON SMITH, John Harry | Amministratore | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | 13547380001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bl Retail Warehousing Holding Company Limited | 06 apr 2017 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Bl Retail Warehousing Holding Company Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 17 giu 2009 Consegnato il 22 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/A title of the homebase store twickenham road feltham with full title guarantee and free from any other security interest and otherwise by way of fixed charge, all legal interests in the property see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 giu 2009 Consegnato il 22 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/A title of the homebase store north side of sandy's hill lane frome somerset with full title guarantee and free from any other security interest and otherwise by way of fixed charge, all legal interests in the property see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 giu 2009 Consegnato il 22 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/A title of the homebase store rushworth road reigate surrey with full title guarantee and free from any other security interest and otherwise by way of fixed charge, all legal interests in the property see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A twenty-first supplemental composite trust deed | Creato il 24 apr 2009 Consegnato il 29 apr 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the principal of and interest on all the debentures | |
Brevi particolari The f/h land show edged with red on the plan of the title being land on the north side of broadway royton t/n GM821517. The f/h land shown edged with red being land lying to the north of broadway royton t/n GM550159. The f/h land shown edged with red being land on the north side of broadway royton t/n GM686645. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fourth supplemental composite trust deed | Creato il 14 mar 2007 Consegnato il 19 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the british land company PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land and buildings on the north side of lower bristol road and the west side of brook road twerton t/n ST2858 all buildings and erections fixtures and fittings fixed plant and machinery benefit of all leases. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Third composite supplemental trust deed | Creato il 01 gen 2007 Consegnato il 10 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the principal of and interest on all the debentures | |
Brevi particolari Land and buildings on the north east side of reigate road ewell t/no sy 670162 and land on the north east side of durnsford road wimbledon t/no sgl 1790947 for further details of property charged please refer to form 395 all together with fixtures erections and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A composite supplemental trust deed | Creato il 29 ago 2006 Acquisito il 01 gen 2007 Consegnato il 24 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Springfield retail park edgar road elgin cuckoo bridge retail park glasgow road dumfries t/nos DMF6641 and DMF6871 and st james retail park dumbarton t/no DMB31472. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A composite supplemental trust deed | Creato il 29 ago 2006 Acquisito il 01 gen 2007 Consegnato il 24 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land and buildings on the north east side of reigate road (ewell homebase) with t/nos SY670162 and SY670947 land on the north east side of durnsford road wimbledon (wimbledon homebase) t/no SGL179482 land lying to the north west ickneild way luton (luton homebase) for details of further properties charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A composite supplemental trust deed | Creato il 29 ago 2006 Consegnato il 13 set 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the british land company PLC as issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The eastgate centre, co-operative house, town square, 2 to 14 (even) east walk, 3 to 9 (odd) south gunnels, 46 to 54 (even) and 81, 83 and 85 southernhay, 10 to 16 gateway, the eastgate business centre, southernhay, kelting house and commercial union house basildon t/no EX363917. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An eleventh supplemental trust deed made between the british land company PLC ("british land"), certain of its subsidiaries (including the company) and royal exchange trust company limited (the "trustee") to the trust supplemental deed dated 29 april 1993 (the "principal trust deed") and ten trust deeds supplemental thereto between (inter alios) british land and trustee | Creato il 30 apr 2001 Consegnato il 14 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The total amount payable under the trust deeds referred to above, namely the principal of, and interest on the £200,000,000 9 3/8 per cent. First mortgage debenture stock 2028 of british land (the "stock") and constituted and secured by a trust deed supplemental to the principal trust deed and all other monies intended to be secured by or payable under or pursuant to the trust deeds or any future trust deed supplemental to the principal trust deed. | |
Brevi particolari By way of a first fixed charge over all companys right title and interest in the property legal and general house st.monica's road kingswood london borough surrey reigate and banstead title number SY641364 together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery for time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An eighth supplemental trust deed dated the 22ND february 1999 | Creato il 22 feb 1999 Consegnato il 09 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the principal trust deed dated 6TH october, 1995 (the "principal trust deed")) whether or not of the same series, and all other monies payable by the issuer to the trustee (as defined in the principal trust deed) under the terms of the principal trust deed | |
Brevi particolari The property known as eastgate shopping centre basildon essex title number EX363917 all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery all existing leases underleases, tenancies, agreements for lease, rights, covenants and conditons. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second supplemental trust deed | Creato il 14 mar 1996 Consegnato il 01 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the principal trust deed dated 6TH october, 1995 (the "principal trust deed")) whether or not of the same series, and all other monies payable by the issuer to the chargee (as defined in the principal trust deed) under the terms of the principal trust deed | |
Brevi particolari Land and buildings on the west side of wheatlea road goose green wigan greater manchester t/n-GM604769. Woodlands court albert drive burgess hill west sussex t/n-WSX186613. Land on the north east side of bull street and the south west side of priory ringway birmingham (k/a temple court) birmingham west midalnds t/n-WM451682 and WM576974.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0