BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED

BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02831648
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLEARTEST LIMITED30 giu 199330 giu 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 nov 2017

    8 pagineLIQ03

    Notifica di Bl Retail Warehousing Holding Company Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2017

    1 paginePSC02

    Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 03 apr 2017

    2 pagineAP01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 7

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 4

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 9

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 6

    5 pagineMR05

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 nov 2016

    LRESSP

    Cessazione della carica di Nigel Mark Webb come amministratore in data 10 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 10 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Andrew Roberts come amministratore in data 10 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Stuart Macey come amministratore in data 10 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Benjamin Toby Grose come amministratore in data 10 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lucinda Margaret Bell come amministratore in data 10 nov 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    BRAINE, Anthony
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Segretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British32809000002
    PENRICE, Victoria Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    190034210001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish32809050044
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Amministratore
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    BRAINE, Anthony
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Amministratore
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Amministratore
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MACEY, Paul Stuart
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205652070001
    MADDISON, John Roman Patrick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish159016320001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Amministratore
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    PENRICE, Victoria Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish189931090001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Amministratore
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritish41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Amministratore
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Amministratore
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritish63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish148183670001
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish148183670001
    VANDEVIVERE, Jean-Marc
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomFrench170947050001
    WEBB, Nigel Mark
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Amministratore
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritish13547380001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2017
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione6002154
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom Companies Registry
    Numero di registrazione6002154
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 17 giu 2009
    Consegnato il 22 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/A title of the homebase store twickenham road feltham with full title guarantee and free from any other security interest and otherwise by way of fixed charge, all legal interests in the property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 2009
    Consegnato il 22 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/A title of the homebase store north side of sandy's hill lane frome somerset with full title guarantee and free from any other security interest and otherwise by way of fixed charge, all legal interests in the property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 2009
    Consegnato il 22 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/A title of the homebase store rushworth road reigate surrey with full title guarantee and free from any other security interest and otherwise by way of fixed charge, all legal interests in the property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A twenty-first supplemental composite trust deed
    Creato il 24 apr 2009
    Consegnato il 29 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the principal of and interest on all the debentures
    Brevi particolari
    The f/h land show edged with red on the plan of the title being land on the north side of broadway royton t/n GM821517. The f/h land shown edged with red being land lying to the north of broadway royton t/n GM550159. The f/h land shown edged with red being land on the north side of broadway royton t/n GM686645. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 29 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fourth supplemental composite trust deed
    Creato il 14 mar 2007
    Consegnato il 19 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the british land company PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of lower bristol road and the west side of brook road twerton t/n ST2858 all buildings and erections fixtures and fittings fixed plant and machinery benefit of all leases.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited as Trustee
    Transazioni
    • 19 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 07 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third composite supplemental trust deed
    Creato il 01 gen 2007
    Consegnato il 10 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the principal of and interest on all the debentures
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north east side of reigate road ewell t/no sy 670162 and land on the north east side of durnsford road wimbledon t/no sgl 1790947 for further details of property charged please refer to form 395 all together with fixtures erections and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ott 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 12 gen 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 07 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A composite supplemental trust deed
    Creato il 29 ago 2006
    Acquisito il 01 gen 2007
    Consegnato il 24 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Springfield retail park edgar road elgin cuckoo bridge retail park glasgow road dumfries t/nos DMF6641 and DMF6871 and st james retail park dumbarton t/no DMB31472.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 24 gen 2007Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 26 mar 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 22 lug 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A composite supplemental trust deed
    Creato il 29 ago 2006
    Acquisito il 01 gen 2007
    Consegnato il 24 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north east side of reigate road (ewell homebase) with t/nos SY670162 and SY670947 land on the north east side of durnsford road wimbledon (wimbledon homebase) t/no SGL179482 land lying to the north west ickneild way luton (luton homebase) for details of further properties charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 24 gen 2007Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 10 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 10 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 20 gen 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 07 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A composite supplemental trust deed
    Creato il 29 ago 2006
    Consegnato il 13 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the british land company PLC as issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The eastgate centre, co-operative house, town square, 2 to 14 (even) east walk, 3 to 9 (odd) south gunnels, 46 to 54 (even) and 81, 83 and 85 southernhay, 10 to 16 gateway, the eastgate business centre, southernhay, kelting house and commercial union house basildon t/no EX363917. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The Trustee)
    Transazioni
    • 13 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An eleventh supplemental trust deed made between the british land company PLC ("british land"), certain of its subsidiaries (including the company) and royal exchange trust company limited (the "trustee") to the trust supplemental deed dated 29 april 1993 (the "principal trust deed") and ten trust deeds supplemental thereto between (inter alios) british land and trustee
    Creato il 30 apr 2001
    Consegnato il 14 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The total amount payable under the trust deeds referred to above, namely the principal of, and interest on the £200,000,000 9 3/8 per cent. First mortgage debenture stock 2028 of british land (the "stock") and constituted and secured by a trust deed supplemental to the principal trust deed and all other monies intended to be secured by or payable under or pursuant to the trust deeds or any future trust deed supplemental to the principal trust deed.
    Brevi particolari
    By way of a first fixed charge over all companys right title and interest in the property legal and general house st.monica's road kingswood london borough surrey reigate and banstead title number SY641364 together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery for time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrances.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited as Trustee for the Holders of Thestock
    Transazioni
    • 14 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 07 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An eighth supplemental trust deed dated the 22ND february 1999
    Creato il 22 feb 1999
    Consegnato il 09 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the principal trust deed dated 6TH october, 1995 (the "principal trust deed")) whether or not of the same series, and all other monies payable by the issuer to the trustee (as defined in the principal trust deed) under the terms of the principal trust deed
    Brevi particolari
    The property known as eastgate shopping centre basildon essex title number EX363917 all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery all existing leases underleases, tenancies, agreements for lease, rights, covenants and conditons.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 09 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second supplemental trust deed
    Creato il 14 mar 1996
    Consegnato il 01 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the principal trust deed dated 6TH october, 1995 (the "principal trust deed")) whether or not of the same series, and all other monies payable by the issuer to the chargee (as defined in the principal trust deed) under the terms of the principal trust deed
    Brevi particolari
    Land and buildings on the west side of wheatlea road goose green wigan greater manchester t/n-GM604769. Woodlands court albert drive burgess hill west sussex t/n-WSX186613. Land on the north east side of bull street and the south west side of priory ringway birmingham (k/a temple court) birmingham west midalnds t/n-WM451682 and WM576974.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited (As Trustee)
    Transazioni
    • 01 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 31 ott 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 feb 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 mar 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 nov 2016Inizio della liquidazione
    02 set 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0