CASTLEGATE 792 LIMITED

CASTLEGATE 792 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLEGATE 792 LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02832192
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CASTLEGATE 792 LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova CASTLEGATE 792 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor 24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLEGATE 792 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INDEPENDENT INSPECTIONS LIMITED01 lug 199301 lug 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEGATE 792 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 apr 2021
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 apr 2022
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CASTLEGATE 792 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 lug 2023
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 lug 2023
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 lug 2022
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEGATE 792 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2024

    20 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Gold Round Limited come amministratore in data 26 set 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2023

    21 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Stuart Pace come amministratore in data 14 dic 2022

    1 pagineTM01

    Modifica dei dettagli di Castlegate 795 Limited come persona con controllo significativo il 06 gen 2023

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 4th Floor Abbey House 32 Booth St Manchester M2 4AB a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW in data 06 gen 2023

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor Abbey House 32 Booth St Manchester M2 4AB in data 22 dic 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 13 dic 2022

    LRESEX

    **Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 5

    5 pagineMR05

    **Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 028321920010

    5 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 028321920009 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 028321920011, creata il 31 ott 2022

    27 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 25 lug 2022

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Independent Inspections Holdings Limited come persona con controllo significativo il 19 apr 2022

    2 paginePSC05

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed independent inspections LIMITED\certificate issued on 22/04/22
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name22 apr 2022

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 19 apr 2022

    RES15

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 21 lug 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 apr 2020

    26 pagineAA

    Cessazione della carica di Alan Albert Horton come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Gold Round Limited il 09 ago 2019

    1 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 29 giu 2020

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CASTLEGATE 792 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02989995
    61999120002
    DICKINSON, Louise
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Segretario
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    British139480580001
    POLLARD, Niall Mackinlay
    57 Royton Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HJ Preston
    Lancashire
    Segretario
    57 Royton Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HJ Preston
    Lancashire
    British176786520001
    WILLS, Debbie
    10 Whitecrest Avenue
    Pheasants Wood
    FY5 2AQ Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Segretario
    10 Whitecrest Avenue
    Pheasants Wood
    FY5 2AQ Thornton Cleveleys
    Lancashire
    British35049700001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARRETT, John
    3 Rockfield Close
    TQ14 8TS Teignmouth
    Devon
    Amministratore
    3 Rockfield Close
    TQ14 8TS Teignmouth
    Devon
    United KingdomBritish118475070001
    DICKINSON, Louise
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish139480580001
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish182208240001
    KNOWLES, Mark Andrew
    79 Park Road
    PR7 1QZ Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    79 Park Road
    PR7 1QZ Chorley
    Lancashire
    British110093240002
    LEE, Peter Francis
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish207608120001
    LEES, Stuart
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Amministratore
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    EnglandBritish70032700001
    LLOYD JONES, Andrew Mark
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish180809810001
    MAHONEY, Kevin David
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    Amministratore
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    United KingdomBritish63238350002
    MAUDE, Simon David
    The Main Hall
    Rufford Park Lane Rufford
    L40 1XE Ormskirk
    1
    Lancashire
    Amministratore
    The Main Hall
    Rufford Park Lane Rufford
    L40 1XE Ormskirk
    1
    Lancashire
    United KingdomBritish89719660003
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish108973030002
    NEWTON, Gordon
    54 Teil Green
    Fulwood
    PR2 9PD Preston
    Lancashire
    Amministratore
    54 Teil Green
    Fulwood
    PR2 9PD Preston
    Lancashire
    British110093300002
    PACE, Stuart
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish207506130003
    POLLARD, Niall Mackinlay
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    6 Fulwood Park Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish176786520001
    RAINES, Steven John
    2 Castle Walk
    Penwortham
    PR1 0BP Preston
    Lancashire
    Amministratore
    2 Castle Walk
    Penwortham
    PR1 0BP Preston
    Lancashire
    British13506670002
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Amministratore
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritish207506140001
    THOMPSON, Peter David
    21 Fleetwood Road
    FY6 7NU Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    21 Fleetwood Road
    FY6 7NU Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British15863610002
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Amministratore
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WATKINS, Steven James
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish127928260002
    WILLIS, Kathleen Jean
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    Lancashire
    Amministratore
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    Lancashire
    British61097710001
    WILLS, Stephen Robert
    Whitelodge 141 Hardhorn Road
    FY6 8ES Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    Whitelodge 141 Hardhorn Road
    FY6 8ES Poulton Le Fylde
    Lancashire
    United KingdomBritish35049690004
    WITHEY, John Alfred
    68 Honiley Drive
    B73 6RW Sutton Coldfield
    Amministratore
    68 Honiley Drive
    B73 6RW Sutton Coldfield
    British35049680001
    GOLD ROUND LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    England
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione05687325
    149588400001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEGATE 792 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gold Round Limited
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    18 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione05687325
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Castlegate 795 Limited
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    06 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione04575239
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CASTLEGATE 792 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 ott 2022
    Consegnato il 07 nov 2022
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Fcap Six Limited
    Transazioni
    • 07 nov 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 01 set 2016
    Consegnato il 13 set 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Blackstar 2016 Limited
    Transazioni
    • 13 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 dic 2022Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 03 giu 2016
    Consegnato il 16 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Secure Trust Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 nov 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 apr 2016
    Consegnato il 22 apr 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Fcap Six Limited
    Transazioni
    • 22 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 31 gen 2011
    Consegnato il 08 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transazioni
    • 08 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 mar 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 giu 2009
    Consegnato il 02 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Investor)
    Transazioni
    • 02 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 giu 2009
    Consegnato il 30 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 30 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2022Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Accession deed
    Creato il 18 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become from any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC in Its Capacity as Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 set 2004
    Consegnato il 21 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Block 6 fulwood park (G2) caxton road north preston employment area preston lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 dic 2002
    Consegnato il 02 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 11 nov 1998
    Consegnato il 24 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 38, 44 & 46 avenham street preston lancashire-LA620828 & LA183448. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CASTLEGATE 792 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 dic 2022Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anthony Collier
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Praticante
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Richard Goodall
    4th Floor Abbey House Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Praticante
    4th Floor Abbey House Booth Street
    M2 4AB Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0