WEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED

WEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02832765
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova WEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Meridian 4 Copthall House
    Station Square
    CV1 2FL Coventry
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PENN HOUSE (GREENOCK) LIMITED24 dic 199924 dic 1999
    WOODSFORD PROPERTIES (GREENOCK) LIMITED23 nov 199323 nov 1993
    WOODSFORD PROPERTIES (SUTTON) LIMITED02 lug 199302 lug 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di WEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per WEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 lug 2012

    Stato del capitale al 06 lug 2012

    • Capitale: GBP 1,968,116
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di WEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOONEY, Stephen
    196 Strathleven Drive
    G83 9PH Alexandria
    Dunbartonshire
    Segretario
    196 Strathleven Drive
    G83 9PH Alexandria
    Dunbartonshire
    British34757960002
    WILSON, Stuart William
    The Cairn, 52
    Prieston Road
    PA11 3AW Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Amministratore
    The Cairn, 52
    Prieston Road
    PA11 3AW Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    United KingdomBritish64932670005
    DALE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200001
    DENHAM, Timothy Maurice
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    Segretario
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    British51492670001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Segretario
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Segretario
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    British2942350001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    MACROBERTS-(FIRM)
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Segretario
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    70181070001
    BONAVERO, Yves Jean Marc
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    Amministratore
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    EnglandFrench29119190003
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    DEVINE, Paul John
    Little Garth 33 Marmion Road
    EH39 4PF North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Little Garth 33 Marmion Road
    EH39 4PF North Berwick
    East Lothian
    British43368870002
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    DUMAS, Markham Cresswell
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    Amministratore
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    United KingdomBritish31098150001
    DUNN, John Alexander
    Flat 2/1
    The Mirus, 822 Maryhill Road
    G77 7TB Glasgow
    Amministratore
    Flat 2/1
    The Mirus, 822 Maryhill Road
    G77 7TB Glasgow
    United KingdomBritish153327440001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Amministratore
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    United KingdomBritish2942350001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    WEST STEWART STREET PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 2002 and
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 17 apr 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or macrocom (715) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the tenant's interest in a lease of all and whole the subjects on the north east side of kilbain street and the south west side of west stewart street, greenock, t/n REN76427 together with (one) the whole buildings erected thereon (two) the fittings and fixtures therein and thereon and (three) the company's whole right, title and interest therein and thereto as tenent under the said lease.
    Persone aventi diritto
    • Morrison Developments Property Finance Limited
    Transazioni
    • 17 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2002 and
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 11 apr 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects on the north east side of kilblain street and the south west side of west stewart street, greenock t/n REN76427.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 02 apr 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The whole of the property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 20 mar 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The whole of the property (including uncalled capital) comprised in the company's property and undertaking.
    Persone aventi diritto
    • Morrison Developments Property Finance Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security dated 18/10/99 which was presented for registration in scotland on 28/10/99
    Creato il 28 ott 1999
    Consegnato il 09 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Property k/a lease of units 1, 2 and 3 and commercial car park at west steward street greenock t/n REN76427.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 18 ott 1999
    Consegnato il 23 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 27 giu 1994
    Consegnato il 30 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums of money due and that may become due from the company to the chargee including without prejudice to that generality all sums of money due and that may become due in terms of the facility comprising the letter agreement between the banque bruxelles lambert france S.A. and the company dated 15 and 17 june 1994 and any variation, extension, renewal, replacement or alteration thereof
    Brevi particolari
    All and whole the tenants interest in the lease between inverclyde district council and ventureline limited of the the former superstore and multi-storey car park situated between kilblain street and west stewart street greenock t/n REN76427.
    Persone aventi diritto
    • Banque Bruxelles Lambert France S.A.
    Transazioni
    • 30 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0