JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED

JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02833805
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED?

    • (4521) /

    Dove si trova JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o DELOITTE LLP
    One Trinity Gardens
    Broad Chare
    NE1 2HF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JARVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED18 apr 199518 apr 1995
    SHANKS & MCEWAN CONSTRUCTION LIMITED27 ott 199327 ott 1993
    DMWSL 132 LIMITED07 lug 199307 lug 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 lug 2012

    15 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    16 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 lug 2011

    5 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:c/o replacement of liquidator
    8 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    9 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Meridian House, the Crescent York North Yorkshire YO24 1AW in data 16 lug 2010

    1 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    9 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 07 lug 2010

    LRESEX

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    17 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    19 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 02 apr 2007

    19 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Segretario
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    70053320013
    KARLSEN, Kjell Konrad
    Apartment 2
    110 Duffield Road
    DE22 1BG Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Apartment 2
    110 Duffield Road
    DE22 1BG Derby
    Derbyshire
    SpainNorwegian119778420002
    LAIRD, Stuart Wilson
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish60742240002
    HODGE, Stanley Bertrand John
    140 Newton Street
    PA16 8SJ Greenock
    Renfrewshire
    Segretario
    140 Newton Street
    PA16 8SJ Greenock
    Renfrewshire
    British914870001
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British20374510001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    BARRON, Michael John
    15 Oakdene Road
    TN13 3HH Sevenoaks
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    15 Oakdene Road
    TN13 3HH Sevenoaks
    Kent
    British900007620001
    BROADBENT, Noel
    21 Kerver Lane
    Dunnington
    YO19 5SL York
    Amministratore
    21 Kerver Lane
    Dunnington
    YO19 5SL York
    EnglandBritish60192070001
    BROOKFIELD, Robert Manuel
    St Margarets
    2 Royal Terrace
    EH49 6HQ Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    St Margarets
    2 Royal Terrace
    EH49 6HQ Linlithgow
    West Lothian
    British38079420001
    CUNNINGHAM, Anthony
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135811090001
    DOWNES, David John
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    Amministratore
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    United KingdomBritish37289200002
    ENTWISTLE, Richard William
    Rosemead Farm
    Moor Monkton
    YO26 8JA York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Rosemead Farm
    Moor Monkton
    YO26 8JA York
    North Yorkshire
    British50174710002
    EVANS, David Clark
    Lyle House
    67 Marsham Way
    SL9 8AW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lyle House
    67 Marsham Way
    SL9 8AW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish102876290001
    FEAST, Roger
    10 Sirius Building Atlantic Wharf
    3 Jardine Road
    E1 9WE London
    Amministratore
    10 Sirius Building Atlantic Wharf
    3 Jardine Road
    E1 9WE London
    British64295140002
    FEAST, Roger
    42 Bounds Oak Way
    TN4 0TN Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    42 Bounds Oak Way
    TN4 0TN Tunbridge Wells
    Kent
    British64295140001
    FITZGERALD, Joseph James
    15 Bentinck Street
    KA4 8HT Galston
    Ayrshire
    Amministratore
    15 Bentinck Street
    KA4 8HT Galston
    Ayrshire
    British9489860001
    FREEBORN, David Michael
    Kettridges
    Wood End
    CB11 3SN Widdington
    Essex
    Amministratore
    Kettridges
    Wood End
    CB11 3SN Widdington
    Essex
    British41022930001
    GALLACHER, Richard William
    7 Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    Amministratore
    7 Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    British60140160002
    GIBSON, Thomas Drummond
    Nellfield House
    Braidwood
    ML8 4PP Carluke
    Lanarkshire
    Amministratore
    Nellfield House
    Braidwood
    ML8 4PP Carluke
    Lanarkshire
    British302540001
    GODDARD, Paul Stephen
    29 Oakland Place
    IG9 5JZ Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    29 Oakland Place
    IG9 5JZ Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritish64788700001
    HURRELL, Stephen Glynn
    8 Holmefield
    Farndon
    NG24 3TZ Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    8 Holmefield
    Farndon
    NG24 3TZ Newark
    Nottinghamshire
    British6552210001
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Amministratore
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritish57954340003
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20374510001
    LAFFERTY, Henry
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    Amministratore
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    EnglandBritish146249130001
    MARTIN, Alan Graham
    12 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore delegato nominato
    12 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    British900007610001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish37404250003
    MCBRIDE, William Anthony Marco
    3 Greta Meek Lane
    G66 8BF Milton Of Campsie
    Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    3 Greta Meek Lane
    G66 8BF Milton Of Campsie
    Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish148250430001
    MOAYEDI, Paris
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish2646590001
    MOAYEDI, Paris
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish2646590001
    NEWMAN, Geoffrey John
    The Cottage
    Little Piggotts
    HP14 4NF North Dean
    Bucks
    Amministratore
    The Cottage
    Little Piggotts
    HP14 4NF North Dean
    Bucks
    British914880001
    RAE, Alistair Kynoch
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    Amministratore
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    EnglandBritish53806830002
    RICHARDSON, Peter Miles
    71 De Tany Court
    AL1 1TX St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    71 De Tany Court
    AL1 1TX St Albans
    Hertfordshire
    British48853120003
    RUSH, Anthony John
    Craigend
    Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Amministratore
    Craigend
    Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    ScotlandBritish526850001
    SUTTON, Andrew John
    Browns End Cottage
    Browns End Road
    CM6 2BE Broxted
    Essex
    Amministratore
    Browns End Cottage
    Browns End Road
    CM6 2BE Broxted
    Essex
    United KingdomBritish110729740001
    WESTBROOK, Bernard Leslie
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish51336870001

    JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security over cash agreement
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 03 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The account being account number 80134554, sorting code 20-72-17 and account name "barclays bank PLC re: jarvis construction (UK) limited" and deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 ott 2002
    Consegnato il 30 ott 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £24,966.65.
    Persone aventi diritto
    • Svm PLC
    Transazioni
    • 30 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 ott 2002
    Consegnato il 24 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £24,996.65 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £24,996.65 paid to great sutton investment co limited as security for the observance and performance of the obligations arising pursuant to the lease together with all sums standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Great Sutton Investment Co Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Intercreditor agreement made between (1) jarvis PLC, (2) wirral schools investment company limited, (3) jarvis construction (UK) limited, (4) jarvis workspace fm limited, (5) societe generale (the "subordinated creditors"), (6) societe generale (as "general security trustee" and as "bridge security trustee") and (7) the borrower (the "agreement").
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 04 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the senior finance liabilities due, owing, or incurred by it to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents. (All terms as defined)
    Brevi particolari
    General undertakings until the senior finance liabilities discharge date, except with the consent of the security trustee: no payment, no set-off, no security, no other action, no amendment, no negotiable instrument, no conversion and no cancellation or transfer.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (As Security Trustee for Itself and the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 04 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Intercreditor agreement
    Creato il 05 dic 1997
    Consegnato il 22 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    All present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the company to any senior creditor (as defined) under or in connection with the finance documents (as defined) together with any refinancing,novation,refunding,deferral or extension of any of those liabilities;any further advances which may be made by a senior creditor to the company under any agreement expressed to be supplemental to any of the finance documents
    Brevi particolari
    If at any time prior to the senior debt discharge date: (a) the contractor receives a payment or distribution in cash or in kind of,or on account of,any of the junior liabilities not permitted by clause 6 (permitted payments) of the intercreditor agreement; (b) the company makes any payment or distribution in cash or in kind to the contractor on account of the purchase or other acquisition of any of the junior liabilities.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Newcourt Capital Inc.,as Agent for and on Behalf of the Finance Parties (In This Capacity the "Agent")
    Transazioni
    • 22 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 apr 1995
    Consegnato il 09 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    JARVIS CONSTRUCTION (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 lug 2010Inizio della liquidazione
    28 set 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ian Brown
    1 Trinity Gardens
    Broad Chare
    NE1 2HF Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    1 Trinity Gardens
    Broad Chare
    NE1 2HF Newcastle Upon Tyne
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0