ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED

ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02834015
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DAYREPORT LIMITED07 lug 199307 lug 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 lug 2018

    11 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 lug 2017

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da 135 Bishopsgate London EC2M 3UR a 250 Bishopsgate London EC2M 4AA in data 17 mar 2017

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    9 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    8 pagineMR04

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    7 pagineMR04

    Stato del capitale al 20 mag 2016

    • Capitale: GBP 100
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 set 2015

    Stato del capitale al 22 set 2015

    • Capitale: GBP 10,000,000
    SH01

    Nomina di Rbs Secretarial Services Limited come segretario in data 08 dic 2014

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Elizabeth Lynxwiler come segretario in data 08 dic 2014

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Segretario
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC269847
    169073830001
    CATO, Guy Howard
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    7th Floor
    Amministratore
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    7th Floor
    EnglandBritish167340790001
    IRISH, Matthew Edward Alphage
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish191076550001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    Segretario
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    British106745220004
    LEA, John Albert
    9 Elderberry Gardens
    CM8 2PT Witham
    Essex
    Segretario
    9 Elderberry Gardens
    CM8 2PT Witham
    Essex
    British1369400001
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Segretario
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    British1369400003
    LYNXWILER, Elizabeth
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    169187130001
    SUTHERLAND, Ian Maclaren
    Littledean
    6 Squirrels Chase
    SK10 4YG Prestbury
    Cheshire
    Segretario
    Littledean
    6 Squirrels Chase
    SK10 4YG Prestbury
    Cheshire
    British33119710003
    THOMAS, Marina Louise
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Segretario
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British80901390001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOAG, Timothy John Donald
    St.Georges Road
    St Margaret's
    TW1 1QS East Twickenham
    23
    Middlesex
    England
    Amministratore
    St.Georges Road
    St Margaret's
    TW1 1QS East Twickenham
    23
    Middlesex
    England
    EnglandBritish62111350003
    BOAG, Timothy John Donald
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    British62111350002
    BROWNE, John Richard
    Gortenanima
    Bovally
    BT49 0GF Limavady
    34
    County Derry
    Northern Ireland
    Amministratore
    Gortenanima
    Bovally
    BT49 0GF Limavady
    34
    County Derry
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish133984130002
    BURDETT, Wayne Francis
    18th Floor
    Repulse Bay Gardens, 32 Belleview Drive
    Hong Kong
    Amministratore
    18th Floor
    Repulse Bay Gardens, 32 Belleview Drive
    Hong Kong
    Australian119566610001
    CARPENTER, Paul
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    Amministratore
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    United KingdomBritish53756030002
    COMMONS, Peter Edmund
    The Paddock 14 Bedford Road
    MK44 3PS Willington
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Paddock 14 Bedford Road
    MK44 3PS Willington
    Bedfordshire
    EnglandBritish269026820001
    CROME, Trevor Douglas
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    EnglandBritish186705800001
    DEVINE, Alan Sinclair
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    United KingdomBritish148842310001
    DEVINE, Alan Sinclair
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    British96634670001
    GREENSHIELDS, John Fraser
    Highfield House
    The Lane
    TN3 0RP Fordcombe
    Kent
    Amministratore
    Highfield House
    The Lane
    TN3 0RP Fordcombe
    Kent
    British62806730003
    HALL, Phillip James
    45 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    45 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    UkBritish106668160001
    HAMILTON, Euan Graeme
    1b Saint Ninians Road
    EH12 8AP Edinburgh
    Amministratore
    1b Saint Ninians Road
    EH12 8AP Edinburgh
    ScotlandScottish96880890001
    HARDY, Thomas William
    28 Piercing Hill
    CM16 7JW Theydon Bois
    Essex
    Amministratore
    28 Piercing Hill
    CM16 7JW Theydon Bois
    Essex
    EnglandBritish40359960002
    HOUSTON, Iain Arthur
    Maple End 10 Hollydell
    SG13 8BE Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maple End 10 Hollydell
    SG13 8BE Hertford
    Hertfordshire
    British8019000001
    JAMESON, Andrew David
    20 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    Amministratore
    20 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    British110180400001
    JONES-MOLYNEUX, Darren Scott
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    EnglandBritish152191300001
    JORDAN, Nicholas Mark
    43 Priory Road
    TW9 3DQ Kew
    Surrey
    Amministratore
    43 Priory Road
    TW9 3DQ Kew
    Surrey
    United KingdomBritish114291290001
    LEA, John Albert
    9 Elderberry Gardens
    CM8 2PT Witham
    Essex
    Amministratore
    9 Elderberry Gardens
    CM8 2PT Witham
    Essex
    British1369400001
    MADDICK, Kevin John
    Ringford Road
    West Hill
    SW18 1RS London
    16
    London
    England
    Amministratore
    Ringford Road
    West Hill
    SW18 1RS London
    16
    London
    England
    United KingdomBritish94650970001
    MCCARTHY, Fiona Louise
    Stock Road
    CM4 9PQ Stock
    Kauri Cottage
    England
    Amministratore
    Stock Road
    CM4 9PQ Stock
    Kauri Cottage
    England
    British103928910001
    MCGRANE, Joseph
    White Lodge
    Erskine Road
    EH31 2DQ Gullane
    East Lothian
    Amministratore
    White Lodge
    Erskine Road
    EH31 2DQ Gullane
    East Lothian
    United KingdomBritish125934450001
    MORRIS, Philip Taylor
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    British35386590001
    MORSE, Lee Robert
    5a Copers Cope Road
    BR3 1PB Beckenham
    Flat 13
    Kent
    Amministratore
    5a Copers Cope Road
    BR3 1PB Beckenham
    Flat 13
    Kent
    EnglandBritish141078840001
    MUDAN, Hurbinder Singh
    Hyde Vale
    Greenwich
    SE10 8QQ London
    27
    England
    Amministratore
    Hyde Vale
    Greenwich
    SE10 8QQ London
    27
    England
    EnglandBritish133983900001
    NAWAS, Michael Eugene, Dr
    Maynes Farmhouse
    Gorhambury
    AL3 6AF St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maynes Farmhouse
    Gorhambury
    AL3 6AF St Albans
    Hertfordshire
    Dutch108365160001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Royal Bank Of Scotland Plc
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    06 apr 2016
    EH2 2YB Edinburgh
    36 St Andrew Square
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1948
    Luogo di registrazioneRegister Of Members
    Numero di registrazioneSc090312
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Account charge
    Creato il 29 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge in respect of the charge account number 31296163, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Consort Healthcare (Birmingham) Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Account charge
    Creato il 29 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge in respect of the charge account number 31296171, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Consort Healthcare (Mid Yorkshire) Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of pledge
    Creato il 22 dic 2000
    Consegnato il 04 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from northlink orkney and shetland ferries limited to the chargee under the terms of any secured document
    Brevi particolari
    The pledgor hereby pledges charges assigns in favour of and transfers to the security trustee for the benefit of and on behalf of itself and the secured creditors the exisiting shares (and the proceeds of sale thereof) and any other charged assets,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of pledge
    Creato il 30 mar 1999
    Consegnato il 01 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from kinnoull house limited to the chargee under the deed and/or under the loan agreement
    Brevi particolari
    The existing shares and the proceeds of sale thereof and any other charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of pledge
    Creato il 12 giu 1998
    Consegnato il 26 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities present and future of covesea limited to the chargee under the terms of the loan agreement of even date, or any of the other financing documents other than the subordinated loan agreements and/or any deed or document supplemental thereto
    Brevi particolari
    The existing shares (and the proceeds of sale thereof), of covesea and any other charged assets to which the pledgors are entitled at the date of the deed and any rights or further shares (and proceeds of sale thereof) to which they become entitled after the date of the deed (rights being all rights (including the right to receive all dividends and other distributions and bonus and scrip rights) pertaining to or deriving from the shares.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Banks,as Defined)
    Transazioni
    • 26 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charges on shares
    Creato il 25 nov 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of tcl to the chargee under each of the operative documents to which tcl is a party and all present and future obligations of the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the charge on shares
    Brevi particolari
    466,593 shares of £1 each in the capital of tcl and 297,454 shares of £1 each in the capital of tcl together with all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Venture Leasing Limited
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge on shares
    Creato il 25 nov 1996
    Consegnato il 12 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any finance party (as defined) and/or hedging bank (as defined) under each finance document (as defined) and all present and future obligations and liabilities of the company to any finance party and/or hedging bank under this charge on shares
    Brevi particolari
    During the first security period, the 466,598 shares in the capital of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dai-Ichi Kangyo Bank Limited, as Security Agent and Trustee for the Finance Parties and Thehedging Banks
    Transazioni
    • 12 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 lug 2017Inizio della liquidazione
    18 gen 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0