TILNEY HOLDINGS LIMITED

TILNEY HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTILNEY HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02834931
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REPORTPROFIT LIMITED09 lug 199309 lug 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2012

    3 pagine4.68

    Cessazione della carica di David Robert Wetherell come amministratore in data 08 ago 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joerg Friedrich Modersohn come amministratore in data 03 ott 2011

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Royal Liver Building Pier Head Liverpool L3 1NY in data 14 ott 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2011

    LRESSP

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 08 giu 2011

    • Capitale: GBP 38,717,197.21
    4 pagineSH01

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 23 giu 2011

    • Capitale: GBP 100
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Subdivision 08/06/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Scissione delle azioni al 08 giu 2011

    5 pagineSH02

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    16 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Nomina di Ian Lewis Bennett come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Zoe Whatmore come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Zoe Victoria Whatmore il 16 mar 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAGSHAW, Joanne Louise
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Segretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British81157100004
    BARTLETT, Andrew William
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Segretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British73852930003
    BENNETT, Ian Lewis
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United KingdomBritish152455200001
    NORBURY, John Douglas
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish8083120003
    WETHERELL, David Robert
    Copley Manor Road
    Thornton Hough
    L63 1JB Wirral
    Merseyside
    Segretario
    Copley Manor Road
    Thornton Hough
    L63 1JB Wirral
    Merseyside
    British41582480001
    WHITFIELD, Robert Jeffery
    Wayside Firs Lane
    Appleton
    WA4 5LD Warrington
    Cheshire
    Segretario
    Wayside Firs Lane
    Appleton
    WA4 5LD Warrington
    Cheshire
    British26088590001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENNETT, Phillip Roger
    125 Colt Lane
    Gladstone
    New Jersey 07934 Usa
    Amministratore
    125 Colt Lane
    Gladstone
    New Jersey 07934 Usa
    British45097010001
    BIRD, Terrence Stanley
    3 Portland Drive
    Clay Hill
    EN2 9AT Enfield
    Amministratore
    3 Portland Drive
    Clay Hill
    EN2 9AT Enfield
    British95741510001
    CAMPBELL, David Alistair
    2 Riverdale Road
    TW1 2BS Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    2 Riverdale Road
    TW1 2BS Twickenham
    Middlesex
    British60653150003
    GRANT, Tone North
    135 South La Salle Street
    Suite 2400
    Chicago
    Illinois 60603
    Usa
    Amministratore
    135 South La Salle Street
    Suite 2400
    Chicago
    Illinois 60603
    Usa
    American26539870001
    GREEN, Peter Robert
    Pineridge
    Lifeboat Road
    L37 2EB Formby
    Merseyside
    Amministratore
    Pineridge
    Lifeboat Road
    L37 2EB Formby
    Merseyside
    British1223440003
    LESSELS, Norman
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    Amministratore
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    British681350002
    MITCHELL, John David
    Ashfield Cottages
    Dark Lane, Higher Whitley
    WA4 4QG Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Ashfield Cottages
    Dark Lane, Higher Whitley
    WA4 4QG Warrington
    Cheshire
    British1172830001
    MODERSOHN, Joerg Friedrich
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Other136313410001
    OKELL, Philip Charles
    Green Butts Farm
    Long Lane
    CW6 9TB Spurstow
    Cheshire
    Amministratore
    Green Butts Farm
    Long Lane
    CW6 9TB Spurstow
    Cheshire
    United KingdomBritish9542910002
    OKELL, Philip Charles
    Shenella Bank Cottage
    Tilstone Fearnall
    CW6 9HP Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Shenella Bank Cottage
    Tilstone Fearnall
    CW6 9HP Tarporley
    Cheshire
    British9542910001
    WEBSTER, David Stephen
    25 Barton Road
    CH47 1HJ Hoylake
    Merseyside
    Amministratore
    25 Barton Road
    CH47 1HJ Hoylake
    Merseyside
    United KingdomBritish83843470001
    WETHERELL, David Robert
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    British41582480002
    WHATMORE, Zoe Victoria
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish163197030001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    TILNEY HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security accession deed
    Creato il 16 mag 2005
    Consegnato il 01 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transazioni
    • 01 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Shares pledge
    Creato il 16 mag 2005
    Consegnato il 01 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the pledgor or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its entire right, title and interest in and to the shares and in and to the securities all dividends, monies and assets in respect of the shares or the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 06 feb 2004
    Consegnato il 19 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the administrative agent and to the vendors or each of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor with full title guarantee and as continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities has charged the securities and the derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert Court as Administrative Agent for and on Behalf of the Vendors
    Transazioni
    • 19 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of pledge
    Creato il 04 ott 1993
    Consegnato il 22 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stocks,shares,bonds debentures and other securities which have been assigned and/or transfered to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 04 ott 1993
    Consegnato il 22 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter d/d 24/09/93 see charge particulars form for details
    Brevi particolari
    All right title and interest in and all benefits accruing from the loan agreement d/d 4/10/93. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 ott 1993
    Consegnato il 22 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TILNEY HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 apr 2013Data di scioglimento
    30 set 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0