CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED

CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONCORDE CONTAINER LINE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02836298
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?

    • Trasporto merci via acqua costiera e marittima (50200) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Maritime Centre
    Port Of Liverpool
    L21 1LA Liverpool
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 lug 2016

    Stato del capitale al 27 lug 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 13 mag 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di John Whittaker come amministratore in data 29 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Eardley Allison come amministratore in data 29 mar 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2015

    Stato del capitale al 05 ago 2015

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Whittaker il 07 apr 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2014

    Stato del capitale al 05 ago 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 25 lug 2013

    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Ian Graeme Lloyd Charnock come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Alan Barr come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARRISON GILL, Caroline Ruth
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Segretario
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Other140064590001
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director165341530001
    WHITWORTH, Mark
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    Amministratore
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    EnglandBritishDirector120679580002
    BOWLEY, William John
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    British4171240002
    BREINGAN, Mark
    6 Raith Drive
    Cumbernauld
    G68 9PE Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    6 Raith Drive
    Cumbernauld
    G68 9PE Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector65773150001
    LANE, John Anthony
    Far Hills
    Grove Road
    HP23 5PA Tring
    Hertfordshire
    Segretario
    Far Hills
    Grove Road
    HP23 5PA Tring
    Hertfordshire
    BritishAccountant17079850001
    LEWIN, Roger
    The Limes Main Road
    Claybrook Magna
    LE17 5AJ Lutterworth
    Leicestershire
    Segretario
    The Limes Main Road
    Claybrook Magna
    LE17 5AJ Lutterworth
    Leicestershire
    BritishShipping Consultant68728770002
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Segretario nominato
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    ALLISON, Thomas Eardley
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritishDirector1037730004
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Amministratore
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritishDirector1037730004
    BARR, Alan Andrew
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    Amministratore
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    ScotlandBritishCompany Director86622660005
    BREINGAN, Mark
    6 Raith Drive
    Cumbernauld
    G68 9PE Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    6 Raith Drive
    Cumbernauld
    G68 9PE Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector65773150001
    FINDLAY, Alastair Ian
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    High Billinge House
    Utkinton
    CW6 0LA Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritishFinance Director30045540003
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Amministratore
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    BritishDirector42038120003
    HIE, John Joseph
    3 Willowbrook
    Derrington
    ST18 9NN Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    3 Willowbrook
    Derrington
    ST18 9NN Stafford
    Staffordshire
    BritishTransport & Sales Director21129960001
    LANE, John Anthony
    Far Hills
    Grove Road
    HP23 5PA Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    Far Hills
    Grove Road
    HP23 5PA Tring
    Hertfordshire
    BritishAccountant17079850001
    LEWIN, Roger
    The Limes Main Road
    Claybrook Magna
    LE17 5AJ Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    The Limes Main Road
    Claybrook Magna
    LE17 5AJ Lutterworth
    Leicestershire
    BritishShipping Consultant68728770002
    PORTER, Allan
    44 Cawder Road
    G68 0BF Cumbernauld
    Amministratore
    44 Cawder Road
    G68 0BF Cumbernauld
    BritishDirector49614260002
    SCOTT, Peter Anthony
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector1674500002
    WHARTON, Kenneth John
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Cornercroft
    7 Glendyke Road
    L18 6JR Liverpool
    Merseyside
    BritishShipping & Overseas Developmen9964160002
    WHITTAKER, John
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Amministratore
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Isle Of ManBritishDirector1614010001
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Amministratore delegato nominato
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security deed of accession
    Creato il 28 feb 2007
    Consegnato il 13 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Secured Creditors
    Transazioni
    • 13 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 mar 2006
    Consegnato il 06 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as security trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 06 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 mag 1999
    Consegnato il 15 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 15 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 apr 1999
    Consegnato il 30 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0