GAME RETAIL (UK) LIMITED

GAME RETAIL (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGAME RETAIL (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02838959
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GAME RETAIL (UK) LIMITED?

    • (5245) /

    Dove si trova GAME RETAIL (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GAME RETAIL (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE ELECTRONICS BOUTIQUE RETAIL (UK) LIMITED08 gen 199608 gen 1996
    FUTURE ZONE GAME CENTRES LIMITED09 mar 199409 mar 1994
    VIRGIN GAMES STORES LIMITED28 ott 199328 ott 1993
    BURGINHALL 718 LIMITED23 lug 199323 lug 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di GAME RETAIL (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 gen 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GAME RETAIL (UK) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GAME RETAIL (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 25 set 2015

    12 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 set 2015

    10 pagine2.24B

    Dimissioni di un amministratore

    1 pagine2.38B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 mar 2015

    10 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 set 2014

    10 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Benjamin White come amministratore in data 08 ago 2014

    2 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 mar 2014

    10 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 feb 2014

    10 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 ago 2013

    9 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 feb 2013

    10 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 set 2012

    12 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Unity House Telford Road Basingstoke Hampshire RG21 6YJ* in data 11 ott 2012

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Ian Shepherd come amministratore

    2 pagineTM01

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    9 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    38 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Vivienne Hemming come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Ian Shepherd come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul John Blunden come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Crowne come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GAME RETAIL (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLUNDEN, Paul John
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritish167658770001
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Segretario
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Segretario
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British125932650001
    LONG, Martin
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    Segretario
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    British125885350001
    GRAY'S INN SECRETARIES LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Segretario nominato
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002550001
    BOYCE, Stephen
    62 Whellock Road
    Chiswick
    W4 1DZ London
    Amministratore
    62 Whellock Road
    Chiswick
    W4 1DZ London
    British87617670001
    BURKE, Simon Paul
    33 St James's Gardens
    W11 4RF London
    Amministratore
    33 St James's Gardens
    W11 4RF London
    Irish30017870002
    CROWNE, Peter Charles
    Fitzroy Road
    GU51 4JW Fleet
    38
    Hampshire
    Uk
    Amministratore
    Fitzroy Road
    GU51 4JW Fleet
    38
    Hampshire
    Uk
    United KingdomBritish106991580002
    CURRAN, Ian
    4 Fowlers Farm Road
    Stokenchurch
    HP14 3PU High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    4 Fowlers Farm Road
    Stokenchurch
    HP14 3PU High Wycombe
    Buckinghamshire
    British37911860002
    GAWTHORNE, Mark David
    10 Gardner Way
    Chandlers Ford
    SO53 1JL Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    10 Gardner Way
    Chandlers Ford
    SO53 1JL Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish117119930001
    HARRIS, Antony Sonny
    137 Britten Close
    NW11 7HW London
    Amministratore
    137 Britten Close
    NW11 7HW London
    British17608740003
    KILBY, Alan James
    105 Lynmouth Crescent
    Furzton Lake
    MK4 1JZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    105 Lynmouth Crescent
    Furzton Lake
    MK4 1JZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish110557200001
    LONG, Martin
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish125885350001
    MARTEL, Nicholas Rupert
    Flat 1 111 St Georges Square
    SW1V 3QP Pimlico
    London
    Amministratore
    Flat 1 111 St Georges Square
    SW1V 3QP Pimlico
    London
    United KingdomBritish83438690001
    MASON, Stephen
    Huckleberry
    7 South Cliff Avenue
    BN20 7AH Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    Huckleberry
    7 South Cliff Avenue
    BN20 7AH Eastbourne
    East Sussex
    British61288000001
    MOLD, Stephen Graham
    61 Chirstchurch Drive
    NN11 4SW Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    61 Chirstchurch Drive
    NN11 4SW Daventry
    Northamptonshire
    British72077760001
    MORGAN, Lisa Jayne
    Cobwebs
    Longwater Road
    RG27 0NW Eversley
    Hampshire
    Amministratore
    Cobwebs
    Longwater Road
    RG27 0NW Eversley
    Hampshire
    British38420460004
    MURDOCH, Graeme
    277 Chester Road
    Streetly
    B74 3EA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    277 Chester Road
    Streetly
    B74 3EA Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish20816940001
    NORRIS, Terence John
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    Amministratore
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritish8778080001
    O'CONNELL, Stephen
    Trebrea Studio
    PL34 0HR Trenale
    Cornwall
    Amministratore
    Trebrea Studio
    PL34 0HR Trenale
    Cornwall
    British112752510001
    PICKUP, Anthony Robert
    5 Old School Court
    School Lane
    MK18 1WE Buckingham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    5 Old School Court
    School Lane
    MK18 1WE Buckingham
    Buckinghamshire
    British49762320003
    RIPLEY, Beverley
    Blackmoor Farm
    Ockham Lane
    KT11 4LZ Chobham
    Surrey
    Amministratore
    Blackmoor Farm
    Ockham Lane
    KT11 4LZ Chobham
    Surrey
    British23762560001
    SHEPHERD, Ian
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish153448920001
    STEINBRECHER, John Mark
    27 St Andrews Gardens
    KT11 1HG Cobham
    Surrey
    Amministratore
    27 St Andrews Gardens
    KT11 1HG Cobham
    Surrey
    American43688810003
    THOMAS, David Fraser
    Farm Drive
    The Webb Estate
    CR8 3LP Purley
    Woodlands
    Surrey
    Amministratore
    Farm Drive
    The Webb Estate
    CR8 3LP Purley
    Woodlands
    Surrey
    EnglandBritish27763020003
    WHITE, Benjamin
    The Row
    Redlynch
    SP5 2JT Nr Salisbury
    Anvil Cottage
    Hampshire
    Uk
    Amministratore
    The Row
    Redlynch
    SP5 2JT Nr Salisbury
    Anvil Cottage
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritish133790090002
    WILSON, Steve
    17 Auckland Road
    KT1 3BG Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    17 Auckland Road
    KT1 3BG Kingston Upon Thames
    Surrey
    British61154320001
    WRIGHT, Simon
    Woods Cottage The Square
    Brightwell-Cum-Sotwell
    OX10 0SB Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Woods Cottage The Square
    Brightwell-Cum-Sotwell
    OX10 0SB Wallingford
    Oxfordshire
    British36786410001
    DH & B DIRECTORS LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Amministratore delegato nominato
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002540001
    DH & B MANAGERS LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Amministratore delegato nominato
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002530001

    GAME RETAIL (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 mag 2007
    Consegnato il 11 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (In Such Capacity,the 'Security Trustee')
    Transazioni
    • 11 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mag 2000
    Consegnato il 12 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 apr 1999
    Consegnato il 28 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 feb 1994
    Consegnato il 04 mar 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)

    GAME RETAIL (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 mar 2012Inizio dell'amministrazione
    25 set 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stuart David Maddison
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Berkshire
    Praticante
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Berkshire
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0