GATEFORTH PARK LIMITED

GATEFORTH PARK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGATEFORTH PARK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02840715
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GATEFORTH PARK LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GATEFORTH PARK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Somerset
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GATEFORTH PARK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOPCHECK LIMITED29 lug 199329 lug 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di GATEFORTH PARK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per GATEFORTH PARK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 29 dic 2017

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 dic 2016

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di John Stanley come amministratore in data 19 set 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 lug 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 29 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 set 2016

    Stato del capitale al 08 set 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Thomas Wilson il 01 feb 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip David Wilson il 16 nov 2015

    4 pagineCH01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Chi sono gli amministratori di GATEFORTH PARK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILSON, Philip
    Haddon Road
    Clontarf
    25
    Dublin 3
    Ireland
    Segretario
    Haddon Road
    Clontarf
    25
    Dublin 3
    Ireland
    Irish107845750001
    WILSON, Paul Thomas
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    Amministratore
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    IrelandIrish175102510004
    WILSON, Philip David
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    Amministratore
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    IrelandIrish176073380001
    WILSON, Ronald Christopher
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Ireland
    Amministratore
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Ireland
    IrelandIrish144024000001
    GARRY, Michael
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Segretario
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish126468430001
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Segretario nominato
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    CLAY, John Andrew
    35 Woodlands View
    Barlby
    YO8 7XL Selby
    North Yorkshire
    Amministratore
    35 Woodlands View
    Barlby
    YO8 7XL Selby
    North Yorkshire
    British75734550001
    FINNAMORE, Des
    Clonkeen
    IRISH Carbury
    County Kildaire
    South Ireland
    Amministratore
    Clonkeen
    IRISH Carbury
    County Kildaire
    South Ireland
    British40604280001
    GARRY, Michael
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Amministratore
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish126468430001
    MACCANNA, Cahal
    29 Castleknock Lodge
    Castleknock
    Dublin
    Dublin 15
    Ireland
    Amministratore
    29 Castleknock Lodge
    Castleknock
    Dublin
    Dublin 15
    Ireland
    Irish66911960001
    MIDDLEBROOK, Simon
    Burton Hall Farm
    Mill Lane Brayton
    YO8 9LD Selby
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Hall Farm
    Mill Lane Brayton
    YO8 9LD Selby
    North Yorkshire
    EnglandBritish48882160001
    SPENCER, Charles Christopher Alwyn
    The Mews
    29 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Mews
    29 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    North Yorkshire
    British76665020001
    STANLEY, John
    Riverside
    Athlumwey
    Navan
    County Meath
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    Riverside
    Athlumwey
    Navan
    County Meath
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish9508050001
    WALKER, David Arthur
    Bank Villa
    Newland Drax
    YO8 8PS Selby
    North Yorkshire
    Amministratore
    Bank Villa
    Newland Drax
    YO8 8PS Selby
    North Yorkshire
    British36079820002
    WALSH, Patrick Anthony
    Barnadown
    IRISH Gorey
    Co Wexford
    Ireland
    Amministratore
    Barnadown
    IRISH Gorey
    Co Wexford
    Ireland
    IrelandIrish63377340001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Amministratore delegato nominato
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GATEFORTH PARK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Decisiondrive Limited
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    C/O Monaghan Mushrooms Limited
    England
    06 apr 2016
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    C/O Monaghan Mushrooms Limited
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies For England And Wales
    Numero di registrazione03742194
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    GATEFORTH PARK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 nov 2011
    Consegnato il 17 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 17 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 ott 2010
    Consegnato il 26 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge the mortgage property,by way of mortgage any deed of easements or rights of way used in connection with the security assets and to the licences and all rights of recovery and compensation,the leases .leasing agreements,agreements for lease or hire purchase agreements see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 26 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 ott 2010
    Consegnato il 26 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge the mortgage property,by way of mortgage any deed of easements or rights of way used in connection with the security assets and to the licences and all rights of recovery and compensation,the leases .leasing agreements,agreements for lease or hire purchase agreements see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 26 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 02 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 02 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture (as defined)
    Creato il 26 ott 2001
    Consegnato il 13 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 13 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 mar 1998
    Consegnato il 08 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 08 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 06 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 06 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0