JADE SOLUTIONS LIMITED

JADE SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJADE SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02842141
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JADE SOLUTIONS LIMITED?

    • Attività di telecomunicazioni cablate (61100) / Informazione e comunicazione
    • Attività di telecomunicazioni senza fili (61200) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova JADE SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Whitwood Lodge
    Whitwood Lane
    WF10 5QD Castleford
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JADE SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JADE COMMUNICATIONS LIMITED04 ago 199304 ago 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di JADE SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per JADE SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Stato del capitale al 10 ott 2022

    • Capitale: GBP 832.223
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 028421410015 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    31 pagineAA

    Nomina di Mr Richard James Gilliard come amministratore in data 21 dic 2021

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Beech House Woodlands Park Ashton Road Newton-Le-Willows Merseyside WA12 0HF England a Whitwood Lodge Whitwood Lane Castleford WF10 5QD in data 29 dic 2021

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Peter Charles Thomson come amministratore in data 21 dic 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Charles Thomson come segretario in data 21 dic 2021

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Mark Brackley come amministratore in data 21 dic 2021

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    31 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    31 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    31 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di JADE SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GILLIARD, Richard James
    Whitwood Lane
    WF10 5QD Castleford
    Whitwood Lodge
    England
    Amministratore
    Whitwood Lane
    WF10 5QD Castleford
    Whitwood Lodge
    England
    EnglandBritish64886600004
    ADAMS, Jennifer
    61 Walsh Avenue
    Warfield
    RG12 6XZ Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    61 Walsh Avenue
    Warfield
    RG12 6XZ Bracknell
    Berkshire
    British35832660002
    BRACKLEY, Mark
    Easby 159 Norley Road
    Cuddington
    CW8 2TB Northwich
    Cheshire
    Segretario
    Easby 159 Norley Road
    Cuddington
    CW8 2TB Northwich
    Cheshire
    British15616530002
    COLE, Jeremy Benjamin
    1 Abbots Barn
    Vale Royal Courtyard Whitegate
    CW8 2BA Northwich
    Cheshire
    Segretario
    1 Abbots Barn
    Vale Royal Courtyard Whitegate
    CW8 2BA Northwich
    Cheshire
    British96851990001
    GREEN, Gary Nigel Alan
    Trudos
    Heath Ride,
    RG40 3QJ Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Trudos
    Heath Ride,
    RG40 3QJ Wokingham
    Berkshire
    British88508030001
    MITZI, Susan Lesley
    28 Hurst Meadow
    Broad Lane
    OL16 4QP Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    28 Hurst Meadow
    Broad Lane
    OL16 4QP Rochdale
    Lancashire
    British104459250001
    SAMPSON, Anthony Brian
    3 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LS Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    3 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LS Altrincham
    Cheshire
    British69523380001
    THELWALL JONES, Simon
    The Hayloft
    Mulsford Lane Sarn
    SY14 7LW Malpas
    Cheshire
    Segretario
    The Hayloft
    Mulsford Lane Sarn
    SY14 7LW Malpas
    Cheshire
    British111111870001
    THOMSON, Peter Charles
    Woodlands Park
    Ashton Road
    WA12 0HF Newton-Le-Willows
    Beech House
    Merseyside
    England
    Segretario
    Woodlands Park
    Ashton Road
    WA12 0HF Newton-Le-Willows
    Beech House
    Merseyside
    England
    British116404140001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BOYD, Moray
    3 Oldstead Grove
    Ferncrest
    BL3 4XW Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    3 Oldstead Grove
    Ferncrest
    BL3 4XW Bolton
    Lancashire
    British60002190001
    BRACKLEY, Mark
    Woodlands Park
    Ashton Road
    WA12 0HF Newton-Le-Willows
    Beech House
    Merseyside
    England
    Amministratore
    Woodlands Park
    Ashton Road
    WA12 0HF Newton-Le-Willows
    Beech House
    Merseyside
    England
    United KingdomBritish15616530006
    GREEN, Gary Nigel Alan
    Trudos
    Heath Ride,
    RG40 3QJ Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trudos
    Heath Ride,
    RG40 3QJ Wokingham
    Berkshire
    British88508030001
    HALBERT, William George
    67 Trematon Place
    Broom Road
    TW11 9RH Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    67 Trematon Place
    Broom Road
    TW11 9RH Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish13311440002
    HAWORTH, Peter
    Gaskyns
    Blundel Lane Stoke D'Abernon
    KT11 2SF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Gaskyns
    Blundel Lane Stoke D'Abernon
    KT11 2SF Cobham
    Surrey
    British70728500001
    MAYO, Peter
    Wharfe View Barn
    Hall Green Lane, North Rigton
    LS17 0DW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wharfe View Barn
    Hall Green Lane, North Rigton
    LS17 0DW Leeds
    West Yorkshire
    England UkBritish69618690003
    NELSON, Alexander
    21 Kilbrennan Road
    Linwood
    PA3 3RG Paisley
    Amministratore
    21 Kilbrennan Road
    Linwood
    PA3 3RG Paisley
    British82900840003
    SAMPSON, Anthony Brian
    3 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LS Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    3 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish69523380001
    SCARLETT, Roger Lionel
    Glen D`Or
    The Ridge
    RG16 9HY Cold Ash
    Berkshire
    Amministratore
    Glen D`Or
    The Ridge
    RG16 9HY Cold Ash
    Berkshire
    British49083740001
    SHARRATT, David
    1 Lark Hill
    Mickleover Country Park Mickleover
    DE3 0US Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    1 Lark Hill
    Mickleover Country Park Mickleover
    DE3 0US Derby
    Derbyshire
    British111112250001
    SHAVE, Colin
    61 Walsh Avenue
    RG42 3XZ Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    61 Walsh Avenue
    RG42 3XZ Warfield
    Berkshire
    EnglandBritish112538410001
    STACK, Richard
    2 Lakefront
    92604 Irvine
    California
    Usa
    Amministratore
    2 Lakefront
    92604 Irvine
    California
    Usa
    American57509660001
    THELWALL JONES, Simon
    The Hayloft
    Mulsford Lane Sarn
    SY14 7LW Malpas
    Cheshire
    Amministratore
    The Hayloft
    Mulsford Lane Sarn
    SY14 7LW Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritish111111870001
    THOMSON, Peter Charles
    Woodlands Park
    Ashton Road
    WA12 0HF Newton-Le-Willows
    Beech House
    Merseyside
    England
    Amministratore
    Woodlands Park
    Ashton Road
    WA12 0HF Newton-Le-Willows
    Beech House
    Merseyside
    England
    WalesBritish116404140001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JADE SOLUTIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Northern Technology Investments Group Limited
    Woodlands Park
    Ashton Road
    WA12 0HF Newton-Le-Willows
    Laurel House
    Merseyside
    England
    30 giu 2016
    Woodlands Park
    Ashton Road
    WA12 0HF Newton-Le-Willows
    Laurel House
    Merseyside
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneUk Companies Register
    Numero di registrazione4261386
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    JADE SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 lug 2017
    Consegnato il 24 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 24 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 ott 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 14 gen 2011
    Consegnato il 02 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form MG01 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re jade communications limited euro currency account, account number 47954699.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2008
    Consegnato il 10 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No.3 a Limited Partnership Acting by Its General Partner Afm Merseyside Ventures Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 lug 2006
    Consegnato il 14 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No.2
    Transazioni
    • 14 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 12 lug 2006
    Consegnato il 14 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the ploicy of insurance of the company with axa on the life of mark brackley (policy no. 31451849) including all new, amended and substituted policy or policies relating thereto and all monies, including bonuses accrued or which may at any time hereafter accrue, which shall become payable thereunder.
    Persone aventi diritto
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No.2
    Transazioni
    • 14 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment the key policy in respect of the life of mark brackley taken out with axa under policy number 31451849 and all money that may become payable under the policy.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurosales Finance PLC
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 05 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of third legal mortgage all f/h and l/h interest in any properties by way of third fixed charge all future f/h and l/h property all estates an interests belonging in or over land or the proceeds of sale of land and all licences now or hereafter held by the company the goodwill and its uncalled capital all receivables by way of third floating charge all the company's undertaking and all its property and assets wherever situated present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mark Brackley
    Transazioni
    • 05 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 02 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from northern technology investments limiter to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the policy including all new amended and substituted policy or policies reltating thereto and all monies including bonuses accrued.
    Persone aventi diritto
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No. 3
    Transazioni
    • 02 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 02 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No.3
    Transazioni
    • 02 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 21 mar 2002
    Consegnato il 22 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 22 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 nov 1998
    Consegnato il 07 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on debts
    Creato il 26 mag 1998
    Consegnato il 30 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a factoring agreement dated 9TH april 1998 or any amendment or addition thereto or replacement thereof
    Brevi particolari
    By way of specific charge all book and other debts owing to the company together with the full benefit of all guarantees securities and indemnities in respect thereof.
    Persone aventi diritto
    • Isis Factors PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0